BELLOTTO ACQUISITION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BELLOTTO ACQUISITION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06252660 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BELLOTTO ACQUISITION LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit 2 Churchill Park Private Road No 2 NG4 2JR Colwick Nottingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BELLOTTO ACQUISITION LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour BELLOTTO ACQUISITION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
État du capital au 21 sept. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 17 déc. 2019
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 18 déc. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Darren Hansel Lock en tant que directeur le 20 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 062526600002 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Richard Thomas le 12 mars 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BELLOTTO ACQUISITION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, David Mathew Aubrey | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 110226830001 | |||||
| RISMAN, John Matthew | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 107350020002 | |||||
| THOMAS, Andrew Richard | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire England | England | British | 154618250004 | |||||
| DOBSON, Kevin Michael | Secrétaire | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | British | 95476170001 | ||||||
| HALL, Fergus Charles Monahan | Secrétaire | 4th Floor 25 Bedford Street WC2E 9ES London | British | 121586810001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BURKE, David Richard Andrew | Administrateur | 4 Adams Court DE7 8YF Ilkeston Derbyshire | British | 61576180002 | ||||||
| CHEEK, Giles Ashley | Administrateur | 37 Yester Road BR7 5HN Chislehurst Kent | United Kingdom | British | 77027280001 | |||||
| DALBY, Simon Andrew | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 110227460002 | |||||
| DOBSON, Kevin Michael | Administrateur | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | United Kingdom | British | 95476170001 | |||||
| HALL, Fergus Charles Monahan | Administrateur | 4th Floor 25 Bedford Street WC2E 9ES London | British | 121586810001 | ||||||
| LOCK, Darren Hansel | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131597650005 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BELLOTTO ACQUISITION LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellotto Finance Limited | 30 juin 2016 | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Unit 2 Churchill Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BELLOTTO ACQUISITION LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 01 août 2014 Livré le 04 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 21 juin 2007 Livré le 02 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0