DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06264686 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2020 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 12 déc. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Ian David Wood en tant que directeur le 19 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Robin James Bryant en tant que directeur le 19 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Preddy en tant que directeur le 19 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 48 pages | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 mars 2019
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Gabriela Pueyo Roberts en tant qu'administrateur le 01 févr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Catherine Elizabeth Barton en tant que directeur le 05 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Dr Steven John Preddy en tant qu'administrateur le 14 sept. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Joseph Coyle en tant que directeur le 14 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| PUEYO ROBERTS, Gabriela | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Spain | Spanish | 254904830001 | |||||||||
| WRIGHT, Jake Hockley | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 184341770001 | |||||||||
| HOLDCROFT, Andrew Darren | Secrétaire | 9 Samford Court Tattingstone IP9 2NQ Ipswich Suffolk | British | 83074650002 | ||||||||||
| HOOPER, Judith Anne | Secrétaire | Oasis Healthcare Support Cntr Vantage Office Park BS16 1GW Old Gloucester Road Hambrook Bristol | 156671650001 | |||||||||||
| MATHARU, Manmohan Singh | Secrétaire | 46 Warren Lane Leicester Forest East LE3 3LW Leicester Leicestershire | British | 49500020001 | ||||||||||
| OWEN, Jennifer Margaret | Secrétaire | Clarence Road AL1 4NW St Albans 138 Hertfordshire | English | 188565910001 | ||||||||||
| TAYLOR, Peter Lance | Secrétaire | Almack House 28 King Street SW1Y 6XA London | British | 92125620001 | ||||||||||
| OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD | Secrétaire | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Vantage Office Park United Kingdom |
| 163512710002 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ASH, Justinian Joseph | Administrateur | Building E Vantage Office Park BS16 1GW Old Gloucester Road Oasis Healthcare Support Centre Hambrook Bristol | England | British | 188659180001 | |||||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 243693740001 | |||||||||
| BELKIN, Jeffrey Philip | Administrateur | 10a Sherriff Road NW6 2AU West Hampstead London | United Kingdom | British | 79906460001 | |||||||||
| BRYANT, Robin James, Dr | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 169089950001 | |||||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Administrateur | Oasis Healthcare Support Cntr Vantage Office Park BS16 1GW Old Gloucester Road Hambrook Bristol | England | British | 113187140001 | |||||||||
| COYLE, Edward Joseph, Dr | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 200405130002 | |||||||||
| HARPER, John | Administrateur | 30 Holmside Road SW12 8RJ London | British | 109430090001 | ||||||||||
| HOFF, Lilimarlen | Administrateur | Flat 7 23 Queensgate Terrace SW7 5PR London | British | 121879120001 | ||||||||||
| HOLDCROFT, Andrew Darren | Administrateur | 9 Samford Court Tattingstone IP9 2NQ Ipswich Suffolk | England | British | 83074650002 | |||||||||
| JOHNSON, Allan | Administrateur | 2 Church Cottages OX20 1DZ Wootton Oxfordshire | England | British | 159246050001 | |||||||||
| LAMBERT, Stephen David | Administrateur | High House 36 South Avenue NR7 0EZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 99698180001 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 135618280010 | |||||||||
| MATHARU, Manmohan Singh | Administrateur | 46 Warren Lane Leicester Forest East LE3 3LW Leicester Leicestershire | England | British | 49500020001 | |||||||||
| PERRY, Julian Francis | Administrateur | Oasis Healthcare Support Cntr Vantage Office Park BS16 1GW Old Gloucester Road Hambrook Bristol | England | British | 84437900002 | |||||||||
| PHILLIPS, David Anthony, Dr | Administrateur | Oasis Healthcare Support Cntr Vantage Office Park BS16 1GW Old Gloucester Road Hambrook Bristol | England | British | 89866810001 | |||||||||
| PREDDY, Steven John, Dr | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 250614010001 | |||||||||
| TAYLOR, Peter Lance | Administrateur | Almack House 28 King Street SW1Y 6XA London | British | 92125620001 | ||||||||||
| TINDALL, Zoe | Administrateur | Portbury Lane Portbury BS20 7SN Bristol Higher Farm Barn North Somerset | Wales | British | 138730340001 | |||||||||
| WOOD, Ian David | Administrateur | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 156407970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Street Capital Oasis Midco Limited | 06 avr. 2016 | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
DUKE STREET CAPITAL OASIS ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 25 juil. 2014 Livré le 31 juil. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 25 juil. 2014 Livré le 31 juil. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A security agreement | Créé le 13 juin 2007 Livré le 22 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0