SENTURION (MIDCO) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SENTURION (MIDCO) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06270218 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SENTURION (MIDCO) LIMITED ?
Adresse du siège social | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SENTURION (MIDCO) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour SENTURION (MIDCO) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2016 | 17 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Bethan Melges le 08 déc. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anoop Kang en tant que directeur le 22 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Adrian Paul Jones en tant qu'administrateur le 22 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2015 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Neville Benson en tant que directeur le 09 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Anoop Kang en tant qu'administrateur le 07 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Divers Section 519 | 1 pages | MISC | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 4 pages | AUD | ||||||||||
Nomination de Mrs Bethan Melges en tant que secrétaire le 16 juil. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mrs Bethan Melges en tant qu'administrateur le 16 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Armitage en tant que secrétaire le 16 juil. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Armitage en tant que directeur le 16 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Hugh Edward Earle Raven en tant que directeur le 16 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Armitage en tant qu'administrateur le 16 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Haydn Jonathan Mursell en tant que directeur le 16 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2014 | 17 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SENTURION (MIDCO) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELGES, Bethan | Secrétaire | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 199623400001 | |||||||
JONES, Adrian Paul | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | Director | 204461800001 | ||||
MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | Chartered Secretary | 199583330002 | ||||
ARMITAGE, Matthew | Secrétaire | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 193481140001 | |||||||
FOULDS, David Michael | Secrétaire | 8 Upper Hollis HP16 9HP Great Missenden Buckinghamshire | British | 122016350001 | ||||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Secrétaire | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | 179700570001 | |||||||
HOWELL, Simon John | Secrétaire | Trowse NR14 8SZ Norwich Senturion (Midco) Limited Norfolk United Kingdom | 165036100001 | |||||||
ARMITAGE, Matthew | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 192052540001 | ||||
BALDWIN, Michael Leonard | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 156130560001 | ||||
BENSON, David Neville | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Financial Controller | 268612760001 | ||||
FELLOWES-PRYNNE, Philip Windover | Administrateur | Trowse NR14 8SZ Norwich Senturion (Midco) Limited Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 179193160001 | ||||
FOULDS, David Michael | Administrateur | 8 Upper Hollis HP16 9HP Great Missenden Buckinghamshire | England | British | Company Director | 122016350001 | ||||
HAZLEWOOD, Mark Antony | Administrateur | Trowse NR14 8SZ Norwich Senturion (Midco) Limited Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 263679050001 | ||||
JAGO, Stephen | Administrateur | 9 Hoober Avenue S11 9SG Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 14271520001 | ||||
JOHNSON, Duncan Edward | Administrateur | Baigens Winchester Road GU34 1SL Chawton Hampshire | United Kingdom | British | Director | 266556880001 | ||||
KANG, Anoop | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | Director | 198683900001 | ||||
MACDIARMID, Donald William | Administrateur | Trowse NR14 8SZ Norwich Senturion (Midco) Limited Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 64347580002 | ||||
MURSELL, Haydn Jonathan | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 179634960001 | ||||
RAVEN, Hugh Edward Earle | Administrateur | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | England | British | General Counsel | 287037230001 | ||||
ROBERTS, Paul Christopher | Administrateur | 34 Ashchurch Grove W12 9BU London | British | Company Director | 59926960002 | |||||
SERNA, Margaret Joan | Administrateur | Bleak House High Street South Kyme LN5 9SN Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 165027770001 | ||||
SOULBY, John Douglas | Administrateur | Ash Tree House 25 Eastfield Lane Welton LN2 3NA Lincoln | British | Director | 51916990002 | |||||
STEVENS, Matthew | Administrateur | Trowse NR14 8SZ Norwich Senturion (Midco) Limited Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 147841500002 | ||||
WOOD, Paul Spencer | Administrateur | 3 The Close Stannington NE61 6HS Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Director | 41271670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SENTURION (MIDCO) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senturion Group Limited | 06 avr. 2016 | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SENTURION (MIDCO) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 08 nov. 2011 Livré le 11 nov. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 juil. 2007 Livré le 13 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 juil. 2007 Livré le 13 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security agreement | Créé le 10 juil. 2007 Livré le 13 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all its properties acquired after the date of the agreement, property interests, equipment, securities, securities system rights, intellectual property, insurance policies, debts, accounts, pension fund interests, goodwill and uncalled capital and other rights. Assignment of the benefit of the assigned documents. Floating charge all of its undertaking, property assets and rights.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0