STORAGE UK SPV1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTORAGE UK SPV1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06271294
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    • Exploitation d'entrepôts et de terminaux de stockage pour le transport terrestre (52103) / Transports et stockage

    Où se situe STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brittanic House
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Hertfordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MACQUARIE STORAGE UK SPV 1 LIMITED06 juin 200706 juin 2007

    Quels sont les derniers comptes de STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 nov. 2019

    8 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Cessation de la nomination de Sam Ahmed en tant que secrétaire le 30 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes modifiés pour une petite société jusqu'au 30 sept. 2015

    14 pagesAAMD

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 25 sept. 2018

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2017 au 31 oct. 2017

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Rajveer Ranawat en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Akbar Abdul Rafiq en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Diego Arroyo en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mehran Charania en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Federico Oliva en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 062712940004 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 062712940005 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Andrew Brian Jones en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Federico Vecchioli en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Sam Ahmed en tant que secrétaire le 01 nov. 2017

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Andrew Brian
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    EnglandEnglish178066050001
    VECCHIOLI, Federico
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    EnglandFrench158800170002
    AHMED, Sam
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    239683830001
    GREENFIELD, James William
    Orkney Gardens
    SS12 9GS Wickford
    5
    Essex
    Secrétaire
    Orkney Gardens
    SS12 9GS Wickford
    5
    Essex
    British131060960001
    TALLENTIRE, Robert John
    Stormore
    9 Green Lane
    WD19 4NL Oxhey
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Stormore
    9 Green Lane
    WD19 4NL Oxhey
    Hertfordshire
    New Zealander91810370005
    GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC287766
    110304810001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ARROYO, Diego
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    EnglandMexican192493040001
    BAILLIE, Mark William
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Australian112156520002
    CARPENTER, Malcolm Edward
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Administrateur
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British115886430001
    CHARANIA, Mehran
    Dorset Street
    W1U 6QU London
    11 Bryanston House
    United Kingdom
    Administrateur
    Dorset Street
    W1U 6QU London
    11 Bryanston House
    United Kingdom
    United KingdomBelgian104274770001
    CLARKE, Christine
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Administrateur
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    British138932540001
    HODGSON, Simon Squair
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    Administrateur
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    ScotlandBritish89025200003
    JACK, Alister William
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish159211330001
    JEFFREY, Alexander Daniel
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    Administrateur
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    United KingdomBritish129962520001
    LANDALE, Peter David Roper
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish49635220001
    LUCCIONI, Laurent Xavier
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Administrateur
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    United KingdomFrench131705720001
    OLIVA, Federico
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    United KingdomItalian192494390001
    PERUSAT, Marc Michel
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    Administrateur
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United KingdomFrench115589250001
    PULIDO, Rena
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Administrateur
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Australian122049340001
    RAFIQ, Akbar Abdul Aziz
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    EnglandBritish,Pakistani192308760001
    RANAWAT, Rajveer
    Chatsworth Road
    Cricklewood
    NW2 4BT London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    Chatsworth Road
    Cricklewood
    NW2 4BT London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish179208350001
    SANTER, Christopher John
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    Administrateur
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    EnglandBritish128404730001
    SMITH, Nathan Robert
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Administrateur
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Australian136694070001
    TALLENTIRE, Robert John
    Stormore
    9 Green Lane
    WD19 4NL Oxhey
    Hertfordshire
    Administrateur
    Stormore
    9 Green Lane
    WD19 4NL Oxhey
    Hertfordshire
    United KingdomNew Zealander91810370005
    TAYLOR, Michael James
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Administrateur
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Australian128209530001
    WONG, Lilian
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Administrateur
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Australian139160950001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STORAGE UK SPV1 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Alligator Storage Centres Ltd
    37 Duke Street
    W1U 1LN London
    3rd Floor
    England
    06 avr. 2016
    37 Duke Street
    W1U 1LN London
    3rd Floor
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom Company Law
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc371272
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    STORAGE UK SPV1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 oct. 2014
    Livré le 28 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 28 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 oct. 2014
    Livré le 28 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 28 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 juin 2012
    Livré le 07 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 janv. 2010
    Livré le 09 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due form each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 09 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 2007
    Livré le 08 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 08 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    STORAGE UK SPV1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    30 nov. 2018Commencement of winding up
    09 mars 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Steven Sherry
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0