STORAGE UK SPV1 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STORAGE UK SPV1 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06271294 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STORAGE UK SPV1 LIMITED ?
| Adresse du siège social | Brittanic House Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Hertfordshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STORAGE UK SPV1 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour STORAGE UK SPV1 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 7 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 nov. 2019 | 8 pages | LIQ03 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sam Ahmed en tant que secrétaire le 30 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes modifiés pour une petite société jusqu'au 30 sept. 2015 | 14 pages | AAMD | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 25 sept. 2018
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2017 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2017 au 31 oct. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rajveer Ranawat en tant que directeur le 01 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Akbar Abdul Rafiq en tant que directeur le 01 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Diego Arroyo en tant que directeur le 01 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mehran Charania en tant que directeur le 01 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Federico Oliva en tant que directeur le 01 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 062712940004 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 062712940005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Brian Jones en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Federico Vecchioli en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Sam Ahmed en tant que secrétaire le 01 nov. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STORAGE UK SPV1 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Andrew Brian | Administrateur | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Brittanic House Hertfordshire England | England | English | 178066050001 | |||||||||
| VECCHIOLI, Federico | Administrateur | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Brittanic House Hertfordshire England | England | French | 158800170002 | |||||||||
| AHMED, Sam | Secrétaire | Stirling Way WD6 2BT Borehamwood Brittanic House Hertfordshire England | 239683830001 | |||||||||||
| GREENFIELD, James William | Secrétaire | Orkney Gardens SS12 9GS Wickford 5 Essex | British | 131060960001 | ||||||||||
| TALLENTIRE, Robert John | Secrétaire | Stormore 9 Green Lane WD19 4NL Oxhey Hertfordshire | New Zealander | 91810370005 | ||||||||||
| GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Atholl Crescent EH3 8EJ Edinburgh 5 Midlothian United Kingdom |
| 110304810001 | ||||||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
| ARROYO, Diego | Administrateur | Savile Row W1S 2ET London 23 United Kingdom | England | Mexican | 192493040001 | |||||||||
| BAILLIE, Mark William | Administrateur | Little Stream Woodlands Road West GU25 4PN Virginia Water Surrey | Australian | 112156520002 | ||||||||||
| CARPENTER, Malcolm Edward | Administrateur | 100 Pennycress Way MK16 8TT Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 115886430001 | ||||||||||
| CHARANIA, Mehran | Administrateur | Dorset Street W1U 6QU London 11 Bryanston House United Kingdom | United Kingdom | Belgian | 104274770001 | |||||||||
| CLARKE, Christine | Administrateur | Sloane Avenue SW3 3XB London Mgpa 60 United Kingdom | British | 138932540001 | ||||||||||
| HODGSON, Simon Squair | Administrateur | Atholl Crescent EH3 8EJ Edinburgh 5 Midlothian | Scotland | British | 89025200003 | |||||||||
| JACK, Alister William | Administrateur | Atholl Crescent EH3 8EJ Edinburgh 5 Midlothian United Kingdom | Scotland | British | 159211330001 | |||||||||
| JEFFREY, Alexander Daniel | Administrateur | Ainger Road NW 3AH London 46a | United Kingdom | British | 129962520001 | |||||||||
| LANDALE, Peter David Roper | Administrateur | Atholl Crescent EH3 8EJ Edinburgh 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 49635220001 | |||||||||
| LUCCIONI, Laurent Xavier | Administrateur | Sloane Avenue SW3 3XB London Mgpa 60 United Kingdom | United Kingdom | French | 131705720001 | |||||||||
| OLIVA, Federico | Administrateur | Savile Row W1S 2ET London 23 United Kingdom | United Kingdom | Italian | 192494390001 | |||||||||
| PERUSAT, Marc Michel | Administrateur | Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Level 35 | United Kingdom | French | 115589250001 | |||||||||
| PULIDO, Rena | Administrateur | 125 W Delaware Place FOREIGN Chicago Illinois Il 60610 United States | Australian | 122049340001 | ||||||||||
| RAFIQ, Akbar Abdul Aziz | Administrateur | Savile Row W1S 2ET London 23 United Kingdom | England | British,Pakistani | 192308760001 | |||||||||
| RANAWAT, Rajveer | Administrateur | Chatsworth Road Cricklewood NW2 4BT London 40 United Kingdom | England | British | 179208350001 | |||||||||
| SANTER, Christopher John | Administrateur | Jedburgh Street Clapham SW11 5QB London 6 | England | British | 128404730001 | |||||||||
| SMITH, Nathan Robert | Administrateur | Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Level 35 United Kingdom | Australian | 136694070001 | ||||||||||
| TALLENTIRE, Robert John | Administrateur | Stormore 9 Green Lane WD19 4NL Oxhey Hertfordshire | United Kingdom | New Zealander | 91810370005 | |||||||||
| TAYLOR, Michael James | Administrateur | Stanley Hill Ave Amersham HP7 9BB London 39 United Kingdom | Australian | 128209530001 | ||||||||||
| WONG, Lilian | Administrateur | Martin Place 2000 Syndney 1 New South Wales Australia | Australian | 139160950001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STORAGE UK SPV1 LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Storage Centres Ltd | 06 avr. 2016 | 37 Duke Street W1U 1LN London 3rd Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
STORAGE UK SPV1 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 16 oct. 2014 Livré le 28 oct. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 16 oct. 2014 Livré le 28 oct. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 juin 2012 Livré le 07 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 janv. 2010 Livré le 09 févr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due form each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 oct. 2007 Livré le 08 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
STORAGE UK SPV1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0