HT FORREST HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HT FORREST HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06287852 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 01 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 19 pages | LIQ14 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2020 | 20 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Nicholson en tant que directeur le 25 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Yard Dodd Lane Westhoughton Bolton BL5 3NU à Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB le 26 avr. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des affaires | 8 pages | LIQ02 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Alan Reid en tant que directeur le 07 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Dwf Llp 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Dwf Llp 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Keith Alan Reid le 23 nov. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Nicholson en tant qu'administrateur le 29 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Keith Falconer en tant que directeur le 29 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 01 mars 2017 | 12 pages | AA | ||||||||||
legacy | 43 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Forrest Corporate Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2016 | 1 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Lee Scott Mccarren en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 avr. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 29 févr. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEATON, John Dennis | Secrétaire | The Oaks Business Park PR2 5BQ Longridge Beech House Preston United Kingdom | British | 122412440001 | ||||||
| STUBLEY, Caroline | Secrétaire | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard England | 163442360001 | |||||||
| ASKIN, Phillip James | Administrateur | Thornton Steward HG4 4BB Ripon Maple Lodge North Yorkshire | United Kingdom | British | 157704260001 | |||||
| BANTON, David | Administrateur | Cottage Brookfold Lane Harwood BL2 4LT Bolton Asmus Farm United Kingdom | United Kingdom | British | 151547650001 | |||||
| BELL, Jonathan | Administrateur | 11 Minster Drive Davyhulme M41 5HA Manchester Lancashire | England | British | 123082590001 | |||||
| BRAMWELL, David Matthew | Administrateur | Woodlands 2a Woodland Rise WF2 9DL Wakefield West Yorkshire | England | British | 4250980001 | |||||
| CHEW, John Anthony | Administrateur | Farm Commons Lane Balderstone BB2 7LL Blackburn Green House Lancashire | England | British | 47950350002 | |||||
| CROSS, Andrew Raymond | Administrateur | Wallace Lane Forton PR3 0BA Preston Cook Green Farmhouse Lancashire | United Kingdom | British | 151102080001 | |||||
| FALCONER, Andrew Keith | Administrateur | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard | United Kingdom | British | 123080580001 | |||||
| FORREST, Timothy John | Administrateur | Oak Tree Farm Alston PR3 3BL Preston Lancs | England | British | 10823490001 | |||||
| HEATON, John Dennis | Administrateur | The Oaks Business Park PR2 5BQ Longridge Beech House Preston United Kingdom | United Kingdom | British | 122412440001 | |||||
| LYONS, Mark Anthony | Administrateur | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard England | United Kingdom | British | 131377790002 | |||||
| MCCARREN, Lee Scott | Administrateur | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard England | England | British | 107908930001 | |||||
| NICHOLSON, Mark | Administrateur | 4th Floor Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester Frp Advisory Llp | United Kingdom | British | 108067170001 | |||||
| REID, Keith Alan | Administrateur | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard | United Kingdom | British | 179486220003 | |||||
| STUBLEY, Caroline | Administrateur | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard England | United Kingdom | British | 163442060001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Lee Scott Mccarren | 13 juil. 2016 | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
| Forrest Corporate Limited | 20 juin 2016 | Dodd Lane Westhoughton BL5 3NU Bolton The Yard United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
HT FORREST HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 01 mars 2017 Livré le 06 mars 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 01 mars 2017 Livré le 03 mars 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 18 févr. 2015 Livré le 21 févr. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 11 oct. 2013 Livré le 14 mars 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 11 oct. 2013 Livré le 17 oct. 2013 | En cours | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 11 oct. 2013 Livré le 11 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 sept. 2011 Livré le 22 sept. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of a life policy | Créé le 27 nov. 2009 Livré le 02 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All money payable under the policy: insurer: bupa health assurance limited, number: H253023801/ctgb/001, life assured: lee mccarren, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 juil. 2007 Livré le 12 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment of the key-man policies | Créé le 04 juil. 2007 Livré le 12 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Bupa health assurance limited policy number H227375201 andrew raymond cross, bupa health assurance limited policy number H227371101 andrew keith falconer, bupa health assurance limited policy number H227405101 timothy john forrest and bupa health assurance limited policy number H227379301 john anthony chew. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment of a key-man policy | Créé le 04 juil. 2007 Livré le 12 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Bupa health assurance limited policy number H230947301 john dennis heaton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
HT FORREST HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0