HT FORREST HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHT FORREST HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06287852
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2020

    20 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Mark Nicholson en tant que directeur le 25 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de The Yard Dodd Lane Westhoughton Bolton BL5 3NU à Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB le 26 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 03 avr. 2019

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Keith Alan Reid en tant que directeur le 07 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Dwf Llp 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Dwf Llp 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Keith Alan Reid le 23 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Mark Nicholson en tant qu'administrateur le 29 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Keith Falconer en tant que directeur le 29 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 01 mars 2017

    12 pagesAA

    legacy

    43 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Forrest Corporate Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2016

    1 pagesPSC02

    Cessation de Lee Scott Mccarren en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 avr. 2017

    1 pagesPSC07

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 29 févr. 2016

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEATON, John Dennis
    The Oaks Business Park
    PR2 5BQ Longridge
    Beech House
    Preston
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Oaks Business Park
    PR2 5BQ Longridge
    Beech House
    Preston
    United Kingdom
    British122412440001
    STUBLEY, Caroline
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    Secrétaire
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    163442360001
    ASKIN, Phillip James
    Thornton Steward
    HG4 4BB Ripon
    Maple Lodge
    North Yorkshire
    Administrateur
    Thornton Steward
    HG4 4BB Ripon
    Maple Lodge
    North Yorkshire
    United KingdomBritish157704260001
    BANTON, David
    Cottage
    Brookfold Lane Harwood
    BL2 4LT Bolton
    Asmus Farm
    United Kingdom
    Administrateur
    Cottage
    Brookfold Lane Harwood
    BL2 4LT Bolton
    Asmus Farm
    United Kingdom
    United KingdomBritish151547650001
    BELL, Jonathan
    11 Minster Drive
    Davyhulme
    M41 5HA Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    11 Minster Drive
    Davyhulme
    M41 5HA Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish123082590001
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish4250980001
    CHEW, John Anthony
    Farm
    Commons Lane Balderstone
    BB2 7LL Blackburn
    Green House
    Lancashire
    Administrateur
    Farm
    Commons Lane Balderstone
    BB2 7LL Blackburn
    Green House
    Lancashire
    EnglandBritish47950350002
    CROSS, Andrew Raymond
    Wallace Lane
    Forton
    PR3 0BA Preston
    Cook Green Farmhouse
    Lancashire
    Administrateur
    Wallace Lane
    Forton
    PR3 0BA Preston
    Cook Green Farmhouse
    Lancashire
    United KingdomBritish151102080001
    FALCONER, Andrew Keith
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    Administrateur
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    United KingdomBritish123080580001
    FORREST, Timothy John
    Oak Tree Farm
    Alston
    PR3 3BL Preston
    Lancs
    Administrateur
    Oak Tree Farm
    Alston
    PR3 3BL Preston
    Lancs
    EnglandBritish10823490001
    HEATON, John Dennis
    The Oaks Business Park
    PR2 5BQ Longridge
    Beech House
    Preston
    United Kingdom
    Administrateur
    The Oaks Business Park
    PR2 5BQ Longridge
    Beech House
    Preston
    United Kingdom
    United KingdomBritish122412440001
    LYONS, Mark Anthony
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    Administrateur
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    United KingdomBritish131377790002
    MCCARREN, Lee Scott
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    Administrateur
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    EnglandBritish107908930001
    NICHOLSON, Mark
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Frp Advisory Llp
    Administrateur
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Frp Advisory Llp
    United KingdomBritish108067170001
    REID, Keith Alan
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    Administrateur
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    United KingdomBritish179486220003
    STUBLEY, Caroline
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    Administrateur
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    England
    United KingdomBritish163442060001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HT FORREST HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Lee Scott Mccarren
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    13 juil. 2016
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Forrest Corporate Limited
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    United Kingdom
    20 juin 2016
    Dodd Lane
    Westhoughton
    BL5 3NU Bolton
    The Yard
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HT FORREST HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 mars 2017
    Livré le 06 mars 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Palatine Private Equity LLP
    Transactions
    • 06 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 mars 2017
    Livré le 03 mars 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Praetura Ventures (10) LLP
    Transactions
    • 03 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 févr. 2015
    Livré le 21 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Palatine Private Equity LLP (Security Trustee)
    Transactions
    • 21 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 oct. 2013
    Livré le 14 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lee Mccarren as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 14 mars 2014Enregistrement d'une charge avec ordonnance du tribunal pour prolonger (MR01)
    • 07 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 oct. 2013
    Livré le 17 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 oct. 2013
    Livré le 11 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Palatine Private Equity LLP (Security Trustee)
    Transactions
    • 11 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 sept. 2011
    Livré le 22 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 22 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of a life policy
    Créé le 27 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All money payable under the policy: insurer: bupa health assurance limited, number: H253023801/ctgb/001, life assured: lee mccarren, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of the key-man policies
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bupa health assurance limited policy number H227375201 andrew raymond cross, bupa health assurance limited policy number H227371101 andrew keith falconer, bupa health assurance limited policy number H227405101 timothy john forrest and bupa health assurance limited policy number H227379301 john anthony chew.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of a key-man policy
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bupa health assurance limited policy number H230947301 john dennis heaton.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    HT FORREST HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 avr. 2019Commencement of winding up
    18 août 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    practitioner
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Ben Woolrych
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    practitioner
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0