STOCK SPIRITS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTOCK SPIRITS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06288038
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor 107 Cheapside
    EC2V 6DN London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STOCK SPIRITS GROUP LIMITED02 août 200702 août 2007
    CHERRY HOLDINGS (UK) LIMITED20 juin 200720 juin 2007

    Quels sont les derniers comptes de STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2023

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Final dividend declared of £745,428,000 28/09/2023
    RES13

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2022

    46 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Saltgate (Uk) Limited le 14 nov. 2022

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de 27-28 Clement's Lane London EC4N 7AE United Kingdom à 2nd Floor 107 Cheapside London EC2V 6DN le 14 nov. 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Stock Spirits Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 janv. 2022

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Miroslaw Stachowicz en tant que directeur le 31 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr István Tadeusz Szőke en tant qu'administrateur le 01 août 2022

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Solar House Mercury Park Wooburn Green Buckinghamshire HP10 0HH à 27-28 Clement's Lane London EC4N 7AE le 12 sept. 2022

    1 pagesAD01

    Nomination de Saltgate (Uk) Limited en tant que secrétaire le 27 avr. 2022

    2 pagesAP04

    Inscription de la charge 062880380026, créée le 29 mars 2022

    72 pagesMR01

    Inscription de la charge 062880380023, créée le 29 mars 2022

    17 pagesMR01

    Inscription de la charge 062880380024, créée le 29 mars 2022

    29 pagesMR01

    Inscription de la charge 062880380025, créée le 29 mars 2022

    40 pagesMR01

    Inscription de la charge 062880380022, créée le 30 mars 2022

    29 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Raj Paul Singh Bal en tant que directeur le 31 mars 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Colin Weatherley en tant que directeur le 31 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Miroslaw Stachowicz en tant qu'administrateur le 31 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sally Kenward en tant que secrétaire le 31 mars 2022

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2021

    58 pagesAA

    Modification des détails de Stock Spirits Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 janv. 2022

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SALTGATE (UK) LIMITED
    Cheapside
    EC2V 6DN London
    2nd Floor 107
    England
    Secrétaire
    Cheapside
    EC2V 6DN London
    2nd Floor 107
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement06453876
    192229240001
    SZŐKE, István Tadeusz
    Cheapside
    EC2V 6DN London
    2nd Floor 107
    United Kingdom
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6DN London
    2nd Floor 107
    United Kingdom
    United KingdomHungarianCompany Director300006450001
    BICKLE, Justin Andrew
    Eastbury Farm Close
    HA6 3EQ Northwood
    1
    Middlesex
    Secrétaire
    Eastbury Farm Close
    HA6 3EQ Northwood
    1
    Middlesex
    BritishCompany Director112506210002
    GONZALEZ, Elisa Gomez De Bonilla
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    British138555050001
    KENWARD, Sally
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    230538200001
    PETERS, Sheila
    146 Hollybush Street
    Plaistow
    E13 9EB London
    Secrétaire
    146 Hollybush Street
    Plaistow
    E13 9EB London
    British104390110001
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    New Change
    EC4M 9AF London
    One
    Secrétaire
    New Change
    EC4M 9AF London
    One
    126060670001
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Administrateur
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    United KingdomBritishCompany Director38963210007
    BAL, Raj Paul Singh
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChief Financial Officer159331090001
    BICKLE, Justin Andrew
    Eastbury Farm Close
    HA6 3EQ Northwood
    1
    Middlesex
    Administrateur
    Eastbury Farm Close
    HA6 3EQ Northwood
    1
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director112506210002
    DEC, Szymon
    1, Rue Feyder
    Strassen
    L-8026
    Luxembourg
    Administrateur
    1, Rue Feyder
    Strassen
    L-8026
    Luxembourg
    PolishCompany Director122851900001
    EVERITT, Neil John
    The White House Fir Lane
    Steeple Aston
    OX25 4SF Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    The White House Fir Lane
    Steeple Aston
    OX25 4SF Bicester
    Oxfordshire
    BritishDirector108961800001
    HEATH, Christopher
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChief Financial Officer181992510001
    JACKSON, Veronica Lesley
    Mercury Park
    HP10 0HH Woodburn Green
    Solar House
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    Mercury Park
    HP10 0HH Woodburn Green
    Solar House
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer255138350001
    KEENAN, John Michael
    Upper Street
    Layham
    IP7 5LE Ipswich
    Layham Hall
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Upper Street
    Layham
    IP7 5LE Ipswich
    Layham Hall
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishManagement Consultant305787040001
    KHAIRALLAH, Karim Michael
    13 Lansdowne Road
    W11 3AG London
    Administrateur
    13 Lansdowne Road
    W11 3AG London
    United KingdomBritishDirector112505580001
    LOWRY, Dorothy Elizabeth
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    ScotlandBritishGroup Hr Director131465700001
    STACHOWICZ, Miroslaw
    Clement's Lane
    EC4N 7AE London
    27-28
    United Kingdom
    Administrateur
    Clement's Lane
    EC4N 7AE London
    27-28
    United Kingdom
    EnglandPolishDirector202864810003
    WEATHERLEY, Steven Colin
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mercury Park
    HP10 0HH Wooburn Green
    Solar House
    Buckinghamshire
    ScotlandBritishLawyer245913720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STOCK SPIRITS (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wycombe Lane
    Wooburn Green
    HP10 0HH High Wycombe
    Solar House
    England
    06 avr. 2016
    Wycombe Lane
    Wooburn Green
    HP10 0HH High Wycombe
    Solar House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleGb: United Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement8687223
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    STOCK SPIRITS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 mars 2022
    Livré le 07 avr. 2022
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch as Pledgee
    Transactions
    • 07 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2022
    Livré le 11 avr. 2022
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 11 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2022
    Livré le 08 avr. 2022
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 08 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2022
    Livré le 08 avr. 2022
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.A. Acting Though Ing Bank N.V., London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 08 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2022
    Livré le 08 avr. 2022
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V. Acting Through Ing Bank N.V., London Branch as Pledgee
    Transactions
    • 08 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2013
    Livré le 21 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 21 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 déc. 2013
    Livré le 21 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 21 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 03 déc. 2012
    Livré le 04 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The tenant's interest in an deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Comland Industrial & Commercial Properties Limited
    Transactions
    • 04 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A pledge and security agreement
    Créé le 08 juin 2012
    Livré le 20 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from ocm, any member of the group and each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in to and under the collateral meaning all pledged stock all material intellectual property and all proceeds see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 20 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement executed outside of the united kingdom over property situated outside of the united kingdom
    Créé le 07 oct. 2011
    Livré le 07 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor and each pledgor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first pledge on the subject of the pledge being the holding and the ancillary rights. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 07 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 07 oct. 2011
    Livré le 19 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any relevant obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The security provider pledges the participation see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 19 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 06 oct. 2011
    Livré le 18 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from ocm by any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch (The Security Agent)
    Transactions
    • 18 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 juil. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    An agreement for a financial pledge
    Créé le 30 sept. 2011
    Livré le 18 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from stock polska sp. Z O.O. and ocm to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A financial pledge over the shares up to the maximum secured amount of eur 330,000.000 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 18 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    An agreement for a registered pledge
    Créé le 30 sept. 2011
    Livré le 18 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company in its capacity as the obligor and ocm in their capacity as the guarantors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Shares up to the maximum secured amount of eur 330,000.000 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 18 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 juin 2008
    Livré le 27 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Comland Industrial and Commercial Properties Limited
    Transactions
    • 27 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed relating to the deed of pledge dated 30 july 2007 and
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor and each lienee to the chargee and any secured creditor see image for full details, on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The subject matter of the pledge being the holding and the connected rights, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (Security Agent) Intesa Sanpaolo S.P.A., Bawag Bank Cz A.S.
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental deed
    Créé le 16 janv. 2008
    Livré le 31 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or any pledgor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The subject matter of the pledge, being the holding and the connected rights, pursuant to article 2471-bis of the civil code. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Secured Creditors, Including Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Agent)
    Transactions
    • 31 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Italian law deed of pledge of share executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor and the company formerly known as cherry holdings (UK) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The subject matter of the pledge, pursuant to article 2471-bis of the civil code. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Secured Creditors Including Abn Amro Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A german law assignment agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatosever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The claims meaning any and all present and future monetary receivables and payment claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A new york law stock pledge agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledged collateral meaning the pledge shares all additional shares securities and interests and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A czech law security agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to a maximum aggregate amount of £1,900,000,000.00 from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The participation meaning all rights and obligations of the security provider as a participant in the company corresponding to its total contribution in the amount of czk 180,000 representing 90% of the registered capital of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A czech law security agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to a maximum aggregate amount of £1,900,000,000.00 from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The participation meaning all rights and obligations of the security provider as a participant in the company corresponding to its total contribution in the amount of czk 180,000 representing 90% of the registered capital of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An austrian law share pledge agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor to a senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares meaning the aggregate of the existing share and any future shares and the ancillary rights meaning and right to receive distributions and any other rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An austrian law share pledge agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor to a senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares meaning the aggregate of the existing share and any future shares and the ancillary rights meaning and right to receive distributions and any other rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An austrian law share pledge agreement
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor to a senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares meaning the aggregate of the existing share and any future shares and the ancillary rights meaning and right to receive distributions and any other rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0