FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED

FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06408324
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gallagher House Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHISWICK LAMB LIMITED24 oct. 200724 oct. 2007

    Quels sont les derniers comptes de FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    XC067U9S

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XBFD3OS3

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022

    8 pagesAA
    ABF2AO7V

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021

    9 pagesAA
    AAID11JL

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XAG25OPC

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X9GGZ5I1

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    14 pagesAA
    A9EAHH20

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    15 pagesAA
    A8J0RE23

    Cessation de la nomination de Neil Tuckey en tant que directeur le 11 nov. 2019

    1 pagesTM01
    X8IRTV01

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8H2HTZE

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7HP4UFT

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    15 pagesAA
    A7DS58JT

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Geoffrey Hugh Gosling le 01 févr. 2017

    2 pagesCH01
    X726B7ZS

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Christopher Gallagher le 01 févr. 2017

    2 pagesCH01
    X726B709

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2018 au 31 mars 2018

    1 pagesAA01
    X7159014

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017

    13 pagesAA
    A6J83CLT

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6HTOBIZ

    Changement d'adresse du siège social de 15 Hockley Court Stratford Road, Hockley Heath Solihull B94 6NW à Gallagher House Gallagher Way, Gallagher Business Park Heathcote Warwick CV34 6AF le 28 mars 2017

    1 pagesAD01
    X634PIIH

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016

    13 pagesAA
    A619PEWX

    Cessation de la nomination de Stephen Andrew Burnett en tant que secrétaire le 01 févr. 2017

    1 pagesTM02
    X5ZP1UCR

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X5IV3SO8

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2015

    13 pagesAA
    A51Y7D9N

    Inscription de la charge 064083240007, créée le 26 févr. 2016

    10 pagesMR01
    X51RGAPD

    Qui sont les dirigeants de FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRADBURY, Caroline Anne
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    Administrateur
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    EnglandBritishDirector114291230003
    GALLAGHER, Anthony Christopher
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    Administrateur
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    United KingdomBritishDirector86375800002
    GOSLING, Geoffrey Hugh
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    Administrateur
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    United KingdomBritishDirector78796680001
    BURNETT, Stephen Andrew
    15 Hockley Court
    Stratford Road, Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    Secrétaire
    15 Hockley Court
    Stratford Road, Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    British66395320004
    MORGAN, Elaine
    6 Lacy Drive
    Bolbeck Park
    MK15 8PL Milton Keynes
    Secrétaire
    6 Lacy Drive
    Bolbeck Park
    MK15 8PL Milton Keynes
    British125389050001
    MORGAN, Mark Paul
    6 Lacy Drive
    Bolbeck Park
    MK15 8PL Milton Keynes
    Administrateur
    6 Lacy Drive
    Bolbeck Park
    MK15 8PL Milton Keynes
    EnglandBritishInstaller125389040001
    TUCKEY, Neil
    Corbiere 13 Liddington Hall Drive
    GU3 3AE Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Corbiere 13 Liddington Hall Drive
    GU3 3AE Guildford
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director49892410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Anthony Christopher Gallagher
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    06 avr. 2016
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mrs Caroline Anne Bradbury
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    06 avr. 2016
    Gallagher Way, Gallagher Business Park
    Heathcote
    CV34 6AF Warwick
    Gallagher House
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    FORTDALE CHESTER SQUARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2016
    Livré le 29 févr. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 29 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2016
    Livré le 29 févr. 2016
    En cours
    Brève description
    Flat 6, albert court, prince consort road, kensington SW7 2BE registered at the land registry with title number NGL957031.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 29 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal charge
    Créé le 12 juil. 2012
    Livré le 14 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 3 netherton grove london t/no NGL165136 by way of fixed charge the benefit of all agreements relating to the property, the rights under the appointment of any managing agent, all rights title and interest in all contracts or policies of insurances, the benefit of all authorisations consents approvals resolutions, rights title and interest in and to the rental income. Assigns all rights title and interest both in rental income and all other rights.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 févr. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2012
    Livré le 14 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 3 netherton grove london t/no NGL165136 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 févr. 2016Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2009
    Livré le 31 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 14 oct. 2009
    Livré le 21 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    44-45 ebury mews t/no NGL462854 f/h 44-45 ebury mews london 45 chester sq t/no NGL814769 f/h 45 chester square london with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 2008
    Livré le 02 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H properties k/a 45 chester square and 44/45 ebury mews london t/nos NGL814769 and NGL462584 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0