LINKS PROPERTY 14 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LINKS PROPERTY 14 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06409041 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LINKS PROPERTY 14 LIMITED ?
Adresse du siège social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LINKS PROPERTY 14 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 21 janv. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LINKS PROPERTY 14 LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour LINKS PROPERTY 14 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 23 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 déc. 2014 | 38 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 35 Great St Helens London EC3A 6AP* le 23 déc. 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 4.70 | |||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 11 déc. 2013
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 21 janv. 2013 | 21 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 18 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 21 janv. 2014 au 31 déc. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 5 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2013 au 21 janv. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed spire property 14 LIMITED\certificate issued on 05/02/13 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB* le 24 janv. 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 120 Holborn London EC1N 2TD* le 23 janv. 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Sfm Corporate Services Limited en tant que secrétaire | 3 pages | AP04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LINKS PROPERTY 14 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 70578490002 | ||||||||||
NOWACKI, John Paul, Mr. | Administrateur | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 | United Kingdom | British | Director | 103195230005 | ||||||||
NURSIAH, Vinoy Rajanah | Administrateur | Great St Helens EC3A 6AP London 35 | United Kingdom | British | Director | 165402030001 | ||||||||
TONER, Daniel Francis | Secrétaire | Holborn EC1N 2TD London 120 | British | 100270040001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 111451340001 | |||||||||||
DE GORTER, Jean Jacques, Dr | Administrateur | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | French | Director | 128865640001 | ||||||||
GORDON, Simon | Administrateur | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | British | Finance Director | 162037020001 | ||||||||
HOLLINGSWORTH, Clare Margaret | Administrateur | House Farm Crowhurst Lane Crowhurst RH7 6LR Lingfield Mansion Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 62952630002 | ||||||||
JONES, Richard James Edward | Administrateur | Holborn EC1N 2TD London 120 | England | British | Director | 133019680001 | ||||||||
ROGER, Robert | Administrateur | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | British | Director | 151959030001 | ||||||||
TONER, Daniel Francis | Administrateur | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | British | Solicitor | 100270040002 | ||||||||
WISE, Robert Jeffrey | Administrateur | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | Australian | Director | 125754410002 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 93433510001 | |||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Administrateur | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 111451340001 |
LINKS PROPERTY 14 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Receivables pledge agreement | Créé le 17 janv. 2013 Livré le 23 janv. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each transaction obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The receivables and all present and future rights, title, claims and interest in the receivables see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 janv. 2013 Livré le 23 janv. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each transaction obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 08 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security accession deed | Créé le 13 juin 2008 Livré le 21 juin 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
LINKS PROPERTY 14 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0