INSITE FACILITY SERVICES LIMITED

INSITE FACILITY SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINSITE FACILITY SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06417467
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Beaufort House
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    3559TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED05 nov. 200705 nov. 2007

    Quels sont les derniers comptes de INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 nov. 2015

    État du capital au 18 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 mars 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Richard Barry Sanders en tant que directeur le 12 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen John Crabb en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Guy Anthony Other en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2014

    État du capital au 01 déc. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 nov. 2013

    État du capital au 13 nov. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Richard Barry Sanders en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Budd en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas Mitchell en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew Lenczer en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Walker en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Oliver Cunningham en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    43 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Qui sont les dirigeants de INSITE FACILITY SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CRABB, Stephen John
    Abbotswood
    HP27 0SR Speen
    4
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Abbotswood
    HP27 0SR Speen
    4
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Other83334300001
    CRABB, Stephen John
    Beaufort House
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    Administrateur
    Beaufort House
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    EnglandBritishFinance Director194023570001
    OTHER, Guy Anthony
    Beaufort House
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    Administrateur
    Beaufort House
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    EnglandBritishChief Executive194022990001
    JUKES, John Kenneth
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    Secrétaire
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    BritishGroup Finance Director52056580002
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    38545840001
    BUDD, Mark Andrew
    House
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector142569110001
    CUNNINGHAM, Oliver Mark
    Bridge Farm Close
    Grove
    OX12 7QF Wantage
    2
    Oxon
    Administrateur
    Bridge Farm Close
    Grove
    OX12 7QF Wantage
    2
    Oxon
    EnglandBritishFinance Director135852790001
    JUKES, John Kenneth
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director52056580002
    LENCZER, Matthew John
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector175066700001
    MITCHELL, Thomas Andrew
    House
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector175069420001
    SANDERS, Richard Barry
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    Beaufort House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    Beaufort House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director173166670001
    WALKER, David Nigel
    14 Claremont Park
    N3 1TH London
    Administrateur
    14 Claremont Park
    N3 1TH London
    United KingdomBritishChief Executive13977660002
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    38761350001
    SERJEANTS'INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    38761340001

    INSITE FACILITY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2013
    Livré le 07 févr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the finance parties) or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine I Gp Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 07 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security interest agreement
    Créé le 09 janv. 2008
    Livré le 24 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First priority security interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2008
    Livré le 23 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Finance Parties)
    Transactions
    • 23 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 09 janv. 2008
    Livré le 23 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100 ordinary shares of euro 1.269738 each in sitex security services limited and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Lenders)
    Transactions
    • 23 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0