VIKING BASINGSTOKE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVIKING BASINGSTOKE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06422041
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VIKING BASINGSTOKE LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente de voitures d'occasion et de véhicules légers (45112) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Entretien et réparation de véhicules automobiles (45200) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Commerce de détail de pièces et accessoires pour véhicules automobiles (45320) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe VIKING BASINGSTOKE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    Arlington Business Park
    Theale
    RD7 4SD Reading
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de VIKING BASINGSTOKE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour VIKING BASINGSTOKE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    24 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 20 mars 2017

    27 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    39 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Houndmills Autoplaza Aldermaston Road Basingstoke Hampshire RG21 6YL United Kingdom à C/O Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading RD7 4SD le 25 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Nomination de Condatis Limited en tant qu'administrateur le 12 sept. 2016

    2 pagesAP02

    Changement d'adresse du siège social de C/O City Motor Holdings Head Office Houndmills Autoplaza Aldermaston Road South Basingstoke Hampshire RG21 6YL à Houndmills Autoplaza Aldermaston Road Basingstoke Hampshire RG21 6YL le 22 août 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Mark Richard Poole en tant que directeur le 31 mai 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher William Robert Hayden en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 nov. 2015

    État du capital au 10 nov. 2015

    • Capital: GBP 325,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 nov. 2014

    État du capital au 14 nov. 2014

    • Capital: GBP 325,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2013

    État du capital au 11 nov. 2013

    • Capital: GBP 325,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    15 pagesAA

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 064220410010

    8 pagesMR01

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de VIKING BASINGSTOKE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RJP SECRETARIES LIMITED
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2989995
    61999120002
    HAYDEN, Christopher William Robert
    c/o Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    Theale
    RD7 4SD Reading
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    Theale
    RD7 4SD Reading
    United KingdomBritishCompany Director208268570001
    CONDATIS LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07666019
    170163900001
    OBS24 LLP
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    Administrateur
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementOC374115
    175034560001
    MORTIMER, Andrew Paul James
    c/o City Motor Holdings
    Houndmills Autoplaza
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Head Office
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o City Motor Holdings
    Houndmills Autoplaza
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Head Office
    Hampshire
    United Kingdom
    British134750630001
    POOLE, Mark Richard
    c/o City Motor Holdings
    Houndmills Autoplaza
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Head Office
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o City Motor Holdings
    Houndmills Autoplaza
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Head Office
    Hampshire
    United Kingdom
    163650080001
    WICKINS, Michael Anthony
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    Secrétaire
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    BritishDirector114468860007
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Secrétaire
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    38915800008
    MORGAN, Derek Anthony
    The Homestead
    Shenley Church End
    MK5 6DJ Milton Keynes
    Administrateur
    The Homestead
    Shenley Church End
    MK5 6DJ Milton Keynes
    United KingdomBritishCompany Director51781140002
    POOLE, Mark Richard
    c/o City Motor Holdings
    Houndmills Autoplaza
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Head Office
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o City Motor Holdings
    Houndmills Autoplaza
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Head Office
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director174874030001
    WALKER, Gavin Robert
    Highcliffe Close
    EX12 2QA Seaton
    Highcliff Lodge
    Devon
    United Kingdom
    Administrateur
    Highcliffe Close
    EX12 2QA Seaton
    Highcliff Lodge
    Devon
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant128424740001
    WICKINS, Anthony John
    Valdoe House
    East Lavant
    PO18 8AW Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Valdoe House
    East Lavant
    PO18 8AW Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector2541040001
    WICKINS, Michael Anthony
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    Administrateur
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    EnglandBritishDirector114468860007
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    67781590003

    VIKING BASINGSTOKE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 25 avr. 2013
    Livré le 08 mai 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 03 août 2009
    Livré le 06 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cmh (2007) Limited
    Transactions
    • 06 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 août 2009
    Livré le 05 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 03 août 2009
    Livré le 05 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 17 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silvershine Investments Limited
    Transactions
    • 17 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 11 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and each of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale LTD
    Transactions
    • 11 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 06 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 06 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Black Horse Limited
    Transactions
    • 06 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 06 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Friday Investments Limited
    Transactions
    • 06 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    VIKING BASINGSTOKE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 sept. 2016Administration started
    26 sept. 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William James Wright
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    practitioner
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Stephen John Absolom
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    practitioner
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0