GE MONEY TWO
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GE MONEY TWO |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 06440028 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GE MONEY TWO ?
| Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GE MONEY TWO ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour GE MONEY TWO ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 mai 2022 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 mai 2021 | 8 pages | LIQ03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Building 2 Marlins Meadow Watford WD18 8YA à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 1 pages | AD02 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à Building 2 Marlins Meadow Watford WD18 8YA | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Building 2 Marlins Meadow Watford WD18 8YA United Kingdom à 30 Finsbury Square London EC2A 1AG le 01 juin 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Paul Stewart Girling en tant qu'administrateur le 24 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Samantha Jones en tant que directeur le 24 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Daniel Mark Birchall en tant qu'administrateur le 24 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Edward Taylor en tant que directeur le 24 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Key Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2019 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Ge Money Home Lending Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2019 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Edward Taylor le 02 sept. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 19 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Samantha Jones le 02 sept. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom à Building 2 Marlins Meadow Watford WD18 8YA le 02 sept. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Ge Money Home Lending Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Notification de Ge Money Home Lending Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 déc. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Ge Money Home Lending Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 déc. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GE MONEY TWO ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| BIRCHALL, Daniel Mark | Administrateur | Marlins Meadow WD18 8YA Watford Building 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 268571870001 | |||||||||
| GIRLING, Paul Stewart | Administrateur | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | 225432580001 | |||||||||
| GREEN, Peter Harvey | Secrétaire | 7 Lower Park Road CH4 7BB Chester Cheshire | British | 123086060001 | ||||||||||
| LANG, Tilly | Secrétaire | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | 237650660001 | |||||||||||
| SHAH, Kalpna | Secrétaire | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | 199402180001 | |||||||||||
| FN SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | 136016100001 | |||||||||||
| BERRY, Duncan Gee | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 107695600022 | |||||||||
| BURN, Bryan Adrian Falconer | Administrateur | 13 Woodthorpe Road Putney SW15 6UQ London | England | British | 3114720001 | |||||||||
| CAMERON, Ewan Douglas | Administrateur | 13 Heathfield Gardens W4 4JU London | British | 122900270001 | ||||||||||
| DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131081660001 | |||||||||
| DEVINE, Brendan | Administrateur | 15 Stoneleigh Avenue Shadwell Lane LS17 8FF Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 113265830001 | |||||||||
| EVANS, Kellie Victoria | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 167417000001 | |||||||||
| FERGUSON, Ian George | Administrateur | The Wharf Lacock SN15 2PQ Nr Chippenham Toll Cottage Wiltshire | United Kingdom | British | 133318850001 | |||||||||
| FLYNN, William John | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | British | 99330320002 | ||||||||||
| FRIGULETTO, Michael Paul | Administrateur | 70 Viceroy Court 58-74 Prince Albert Road NW8 7PS London | American | 126734970001 | ||||||||||
| GARDEN, Robert James | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152764360001 | |||||||||
| GILLIGAN, Brendan Edward | Administrateur | 8 Thormanbay Lodge IRISH Howth County Dublin Ireland | Ireland | Irish | 227641150001 | |||||||||
| GREEN, Peter Harvey | Administrateur | 7 Lower Park Road CH4 7BB Chester Cheshire | United Kingdom | British | 123086060001 | |||||||||
| GREENWAY, Anthony William | Administrateur | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | United Kingdom | British | 202871130001 | |||||||||
| GUNNIGLE, Clodagh | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138244630002 | |||||||||
| HARVEY, David | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 97086950001 | |||||||||
| HARVEY, David | Administrateur | Woodcote Andrew Hill Lane SL2 3UL Hedgerley | United Kingdom | British | 97086950001 | |||||||||
| HARVEY, Richard John | Administrateur | 6 Heronsford West Hunsbury NN4 9XG Northampton Northamptonshire | British | 122892160001 | ||||||||||
| JOHAR, Mandeep Singh | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Indian | 127046380002 | |||||||||
| JONES, Samantha | Administrateur | Marlins Meadow WD18 8YA Watford Building 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 216074420001 | |||||||||
| MORRISON, Graeme Sutherland Cowan, Mr. | Administrateur | Thors Norrells Drive KT24 5DL East Horsley Surrey | England | British | 6379770001 | |||||||||
| NAPIER, Richard Stewart | Administrateur | 24 Moulton Lane Boughton NN2 8RF Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 127520470001 | |||||||||
| PERRIN, Laurence Anne Renee | Administrateur | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | United Kingdom | French | 183220720001 | |||||||||
| PHIPPS, Robin Ashley | Administrateur | Tilehurst 9 Furze Hill CR8 3LB Purley Surrey | United Kingdom | British | 28504520002 | |||||||||
| PICKERING, Steven Mark | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire | United Kingdom | British | 164833430002 | |||||||||
| REID, Ian Elmore | Administrateur | Ellison House School Crescent Scothern LN2 2UQ Lincoln Lincolnshire | British | 118850120001 | ||||||||||
| SHAVE, Colin John Varnell | Administrateur | Windsor Road HP9 2JW Beaconsfield Little Hall Barn Bucks United Kingdom | England | Usa And British | 90360350002 | |||||||||
| SHAVE, Colin John Varnell | Administrateur | Little Hall Barn Windsor Road HP9 2JW Beaconsfield Buckinghamshire | England | Usa And British | 90360350002 | |||||||||
| SPARROW, Nigel Kenneth | Administrateur | 55 Church Street Emley HD8 9RP Huddersfield | British | 120147950002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GE MONEY TWO ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Leasing Limited | 11 nov. 2019 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ge Money Home Lending Finance Limited | 13 déc. 2018 | Marlins Meadow WD18 8YA Watford Building 2 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ge Money Home Lending Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Hatters Lane 2497 WD18 8YF Watford Building 4 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GE MONEY TWO a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0