COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED

COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06473281
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITTON FLEXIBLES LIMITED15 janv. 200815 janv. 2008

    Quels sont les derniers comptes de COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    18 pagesLIQ10

    Satisfaction de la charge 064732810007 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 064732810006 en totalité

    4 pagesMR04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Coveris Lealand Way Riverside Industrial Estate Boston Lincolnshire PE21 7SW

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd England à C/O Coveris Lealand Way Riverside Industrial Estate Boston Lincolnshire PE21 7SW

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Unit 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd à 1 More London Place London SE1 2AF le 21 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 sept. 2016

    LRESSP

    Nomination de Mr Glen Philip Harte en tant qu'administrateur le 22 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 064732810007, créée le 18 août 2016

    74 pagesMR01

    Nomination de Mr Mark Edward Lapping en tant qu'administrateur le 25 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Britton Taco Ltd Road One Winsford Industrial Estate, Winsford Cheshire CW7 3rd à Unit 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd le 27 janv. 2016

    1 pagesAD01

    État du capital après une attribution d'actions au 25 sept. 2015

    • Capital: GBP 10,001.00
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Edward Lapping en tant que directeur le 31 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Malcolm Toby en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 janv. 2015

    État du capital au 21 janv. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lee David Richardson en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOSTOCK, Karl Robert
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director188188900001
    HARTE, Glen Philip
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishFinancial Controller177938030001
    LAPPING, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishPresident, Coveris Uk Food & Consumer179783440001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    British42598360003
    RICHARDSON, Lee
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    Secrétaire
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    British177380190002
    ATALLA, Mahmoud Riyad
    Elizabeth Street
    Belgravia
    SW1W 9PP London
    43a
    Administrateur
    Elizabeth Street
    Belgravia
    SW1W 9PP London
    43a
    EnglandBritishInvestor Director128482790001
    CLARK, Michael
    Grand Manor Drive
    FY8 4FY Lytham St. Annes
    21
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Grand Manor Drive
    FY8 4FY Lytham St. Annes
    21
    Lancashire
    England
    EnglandBritishCompany Director92294570002
    DEAN, Darren William
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director114199420001
    DURSTON, John
    The Chimes
    Chantry
    BA11 3LQ Frome
    Somerset
    Administrateur
    The Chimes
    Chantry
    BA11 3LQ Frome
    Somerset
    EnglandBritishInvestor Director2538220001
    FINNERAN, Mark James
    Curtis Close
    DN18 6LE Barton Upon Humber
    Celebration
    North Lincolnshire
    Administrateur
    Curtis Close
    DN18 6LE Barton Upon Humber
    Celebration
    North Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector128482390002
    FOX, Thomas
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    GermanyGermanCompany Director161682620001
    GILL, Christopher Paul
    Silvertrees 18 Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Silvertrees 18 Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishInvestor Director43569560001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritishCompany Director42598360003
    GREIG, William
    9 The Park
    HR1 1TF Hereford
    Administrateur
    9 The Park
    HR1 1TF Hereford
    EnglandBritishDirector62943430001
    LAPPING, Mark Edward
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director188189180001
    MAWBY, Allen
    Priors Court
    Aylton
    HR8 2QE Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    Priors Court
    Aylton
    HR8 2QE Ledbury
    Herefordshire
    United KingdomBritishInvestor Director68092340002
    RICHARDSON, Lee David
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Winsford Industrial
    CW7 3RD Estate, Winsford
    Cheshire
    Administrateur
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Winsford Industrial
    CW7 3RD Estate, Winsford
    Cheshire
    WalesWelshAccountant217305230001
    TOBY, Paul Malcolm
    14 Foxglove Bank
    SG8 9TH Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Foxglove Bank
    SG8 9TH Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector62668470002
    TURNER, Barry John
    Bridge House
    Newby Wiske
    DL7 9EX Northallerton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Bridge House
    Newby Wiske
    DL7 9EX Northallerton
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector178909830001

    COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 août 2016
    Livré le 23 août 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Bank Usa as Collateral Agent
    Transactions
    • 23 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 08 nov. 2013
    Livré le 15 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Bank Usa as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 15 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee and debenture
    Créé le 01 juin 2011
    Livré le 08 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 25 mars 2009
    Livré le 31 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest the excluded proceeds the relevant contracts the insurances the charged accounts and all monies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transactions
    • 31 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 févr. 2008
    Livré le 13 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Michael Clark, as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 13 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 févr. 2008
    Livré le 05 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including buildings fixtures fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank Holdings PLC
    Transactions
    • 05 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 févr. 2008
    Livré le 01 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transactions
    • 01 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 mars 2018Dissolved on
    29 sept. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0