AGENTS GIVING
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AGENTS GIVING |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 06507703 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AGENTS GIVING ?
| Adresse du siège social | First Floor, Gateway House Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh Hampshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AGENTS GIVING ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AGENTS GIVING ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 févr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 mars 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 févr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour AGENTS GIVING ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2024 | 19 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Marcus St John Whewell en tant que directeur le 25 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de Craig Campbell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 févr. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de David Julien Newnes en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 avr. 2023 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de Peter John Knight en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 févr. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Craig Campbell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 févr. 2025 | 2 pages | PSC01 | ||
Nomination de Mr Simon Luther Bradbury en tant qu'administrateur le 27 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Craig Campbell en tant qu'administrateur le 13 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023 | 19 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de PO Box 648 Gateway House Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO50 0nd United Kingdom à First Floor, Gateway House Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG le 08 avr. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Ian Stoop en tant que directeur le 31 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de Michael Ian Stoop en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2021 | 1 pages | PSC07 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Gary Peter Barker en tant que directeur le 26 mars 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 févr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Iain Henry Mckenzie en tant qu'administrateur le 01 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Simon Michael Whale en tant qu'administrateur le 01 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 17 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de The Oriel Sydenham Road Guildford Surrey GU1 3SR England à PO Box 648 Gateway House Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO50 0nd le 21 avr. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 févr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Michael Stoop en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2020 | 2 pages | PSC01 | ||
Qui sont les dirigeants de AGENTS GIVING ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH, Sarah Elizabeth | Secrétaire | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | 201614120001 | |||||||
| BRADBURY, Simon Luther | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 79921070002 | |||||
| CAMPBELL, Craig | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 332835550001 | |||||
| EMERSON, Nathan Russell | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 105680820002 | |||||
| GARDNER, Jane Paula | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 159294330001 | |||||
| GILTINAN, Frances | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 254012440001 | |||||
| KNIGHT, Peter John Talbot | Administrateur | Holmbury Hill Road Holmbury St. Mary RH5 6NR Dorking Hurtwood Place England | England | British | 33273880012 | |||||
| LAWRENCE, Spencer | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 141736070001 | |||||
| MCKENZIE, Iain Henry | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 225104430001 | |||||
| NEWNES, David Julian | Administrateur | North Lane DE6 3BE Brailsford North Farm Derbyshire | England | British | 75640120002 | |||||
| SAMPLES, Gareth Meirion | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 171895420001 | |||||
| WHALE, Simon Michael | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | United Kingdom | British | 115576850002 | |||||
| WRIGHT, Nicholas Kenneth | Secrétaire | The Clockhouse Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol | British | 8571790002 | ||||||
| BAGNALL, Philippa Mary | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | England | British | 117999360001 | |||||
| BAGNALL, Philippa Mary | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | England | British | 117999360001 | |||||
| BARKER, Gary Peter | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO50 0ND Eastleigh PO BOX 648 Gateway House Hampshire United Kingdom | England | British | 197272440001 | |||||
| BUTLER, Mark James | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | England | British | 105911410001 | |||||
| LINDLEY, Malcolm Garland | Administrateur | Common Lane Hemingford Abbots PE28 9AN Huntingdon 13 Cambridgeshire England | England | British | 34518570003 | |||||
| LUCK, Tamsin | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | England | British | 163316450001 | |||||
| MCCLINTOCK, William Ashe | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | United Kingdom | British | 36110280001 | |||||
| MORTON, Lucy Susan Ritchie | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | England | British | 156051240001 | |||||
| NEWMAN, Sean Walter | Administrateur | North Lodge Ashlawn Road CV22 5QG Rugby Warwickshire | England | British | 57568550004 | |||||
| NOTLEY, Jonathan Lewis | Administrateur | Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol The Clockhouse England | England | British | 156050720001 | |||||
| RAINBIRD-CLARKE, Kathryn Lois | Administrateur | Reigate Road KT22 8RA Leatherhead The Chapel Of Ideas Surrey England | England | British | 226680710002 | |||||
| REED, Alec Edward | Administrateur | 6 Sloane Street SW1X 9LE London | England | British | 58790210007 | |||||
| ROBSON, Michael | Administrateur | Bay Tree House The Barton Corston BA2 9AJ Bath | England | British | 8571800002 | |||||
| STOOP, Michael Ian | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO50 0ND Eastleigh PO BOX 648 Gateway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 62948120003 | |||||
| TUCKER, Richard Martin | Administrateur | Sydenham Road GU1 3SR Guildford The Oriel Surrey England | England | British | 114551880001 | |||||
| WHEWELL, Marcus St John | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | England | British | 266587080001 | |||||
| WRIGHT, Nicholas Kenneth | Administrateur | The Clockhouse Bath Hill Keynsham BS31 1HL Bristol | England | British | 8571790002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AGENTS GIVING ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Craig Campbell | 13 févr. 2025 | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr David Julian Newnes | 22 avr. 2023 | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Michael Ian Stoop | 01 janv. 2020 | Tollgate Chandler's Ford SO50 0ND Eastleigh PO BOX 648 Gateway House Hampshire United Kingdom | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Peter John Knight | 06 avr. 2016 | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TG Eastleigh First Floor, Gateway House Hampshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0