C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED

C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06518342
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    International House
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PIMCO 2751 LIMITED29 févr. 200829 févr. 2008

    Quels sont les derniers comptes de C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 065183420005 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 065183420006 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 27 nov. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share prem a/c and capital redemption reserve cancelled 26/11/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 065183420004 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 29 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2018

    39 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 065183420006, créée le 25 juin 2019

    73 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 05 nov. 2018

    • Capital: GBP 203,251.84
    8 pagesSH01

    Subdivision des actions au 05 nov. 2018

    6 pagesSH02

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Sub divided 05/11/2018
    RES13
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    26 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 oct. 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 29/04/2018 as it was not properly delivered.

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    24 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 oct. 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 27/03/2015 as it was not properly delivered.

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    23 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 oct. 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 23/04/2014 as it was not properly delivered.

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    21 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 oct. 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 01/05/2013 as it was not properly delivered.

    Qui sont les dirigeants de C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUXTON, Matthew Robert
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    Secrétaire
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    177913450001
    BRAYSHAW, Nicholas Paul
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    Administrateur
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    EnglandBritishDirector96985570003
    BUXTON, Matthew Robert
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant177912050001
    TILSLEY, Neil Andrew
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    Administrateur
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United KingdomBritishManaging Director232028330001
    BAKER, Stephen Peter
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    Secrétaire
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    BritishCompany Director44068330003
    BOWERBANK, David Christopher
    Deeside Lane
    Sealand
    CH1 6BQ Chester
    1 The Bowery
    Secrétaire
    Deeside Lane
    Sealand
    CH1 6BQ Chester
    1 The Bowery
    British138170880001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BAKER, Stephen Peter
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    Administrateur
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    United KingdomBritishCompany Director44068330003
    FRASER, Nicol Roderick Peter
    2 Murrayfield Road
    EH12 6EJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2 Murrayfield Road
    EH12 6EJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishCompany Director67603430001
    GEORGE, Lionel Michel
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    England
    Administrateur
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    England
    FranceFrenchDirector195550670001
    GOODBURN, Steven John
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    Administrateur
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United KingdomBritishSales Director130123380003
    GUILLOT, Christophe
    Boulevard Arago
    75013
    Paris
    38
    France
    Administrateur
    Boulevard Arago
    75013
    Paris
    38
    France
    FranceFrenchDirector129625350002
    JOLLIFFE, David
    Earls Gate
    Bothwell
    G71 8BP Glasgow
    6a
    United Kingdom
    Administrateur
    Earls Gate
    Bothwell
    G71 8BP Glasgow
    6a
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector151826090002
    MILLWARD, Phillip Robert
    The Cottage
    2a Talbot Road
    WA14 3JD Bowdon
    Cheshire
    Administrateur
    The Cottage
    2a Talbot Road
    WA14 3JD Bowdon
    Cheshire
    BritishCompany Director97811170001
    ROWAN, Simon
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Scotland
    Administrateur
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Scotland
    United KingdomBritishInvestment Director167430200002
    STRANG, James Mark Nelson
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector124509390001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA Merseyside
    International House
    England
    27 sept. 2018
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA Merseyside
    International House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement11563023
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltaire Court
    Scotland
    06 avr. 2016
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltaire Court
    Scotland
    Oui
    Forme juridiquePlc
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc052844
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    32 Gallowgate
    NE1 4SN Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    32 Gallowgate
    NE1 4SN Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLlp
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementOc392261
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 25 juin 2019
    Livré le 05 juil. 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tc Loans I Limited (As Security Trustee of the Secured Parties)
    Transactions
    • 05 juil. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 sept. 2018
    Livré le 10 oct. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Each chargor charges all its right, title and interest by way of first legal mortgage over all land vested in such chargor and all land acquired by such chargor after the date of the instrument. For more details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Eso Capital Partners UK LLP (As Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties)
    Transactions
    • 10 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 sept. 2016
    Livré le 03 oct. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets); and. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets) together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shawbrook Bank Limited T/a Shawbrook Business Credit ("Shawbrook")
    Transactions
    • 03 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 août 2012
    Livré le 12 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 16 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 10 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 10 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0