C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06518342 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | International House Millfield Lane WA11 9GA Haydock Merseyside |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 065183420005 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 065183420006 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | SH20 | ||||||||||||||||||||||
État du capital au 27 nov. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 065183420004 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2018 | 39 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 065183420006, créée le 25 juin 2019 | 73 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 05 nov. 2018
| 8 pages | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Subdivision des actions au 05 nov. 2018 | 6 pages | SH02 | ||||||||||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||||||||||
Détails de la variation des droits attachés aux actions | 2 pages | SH10 | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 26 pages | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 24 pages | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 23 pages | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 21 pages | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXTON, Matthew Robert | Secrétaire | Millfield Lane Haydock WA11 9GA St. Helens International House Merseyside England | 177913450001 | |||||||
BRAYSHAW, Nicholas Paul | Administrateur | Millfield Lane Haydock WA11 9GA St. Helens International House Merseyside England | England | British | Director | 96985570003 | ||||
BUXTON, Matthew Robert | Administrateur | Millfield Lane WA11 9GA Haydock International House Merseyside United Kingdom | England | British | Accountant | 177912050001 | ||||
TILSLEY, Neil Andrew | Administrateur | Millfield Lane WA11 9GA Haydock International House Merseyside | United Kingdom | British | Managing Director | 232028330001 | ||||
BAKER, Stephen Peter | Secrétaire | 37 Rossett Park Darland Lane LL12 0FB Rossett Wrexham | British | Company Director | 44068330003 | |||||
BOWERBANK, David Christopher | Secrétaire | Deeside Lane Sealand CH1 6BQ Chester 1 The Bowery | British | 138170880001 | ||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
BAKER, Stephen Peter | Administrateur | 37 Rossett Park Darland Lane LL12 0FB Rossett Wrexham | United Kingdom | British | Company Director | 44068330003 | ||||
FRASER, Nicol Roderick Peter | Administrateur | 2 Murrayfield Road EH12 6EJ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Company Director | 67603430001 | ||||
GEORGE, Lionel Michel | Administrateur | Millfield Lane WA11 9GA Haydock International House Merseyside England | France | French | Director | 195550670001 | ||||
GOODBURN, Steven John | Administrateur | Millfield Lane WA11 9GA Haydock International House Merseyside | United Kingdom | British | Sales Director | 130123380003 | ||||
GUILLOT, Christophe | Administrateur | Boulevard Arago 75013 Paris 38 France | France | French | Director | 129625350002 | ||||
JOLLIFFE, David | Administrateur | Earls Gate Bothwell G71 8BP Glasgow 6a United Kingdom | Scotland | British | Director | 151826090002 | ||||
MILLWARD, Phillip Robert | Administrateur | The Cottage 2a Talbot Road WA14 3JD Bowdon Cheshire | British | Company Director | 97811170001 | |||||
ROWAN, Simon | Administrateur | Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Scotland | United Kingdom | British | Investment Director | 167430200002 | ||||
STRANG, James Mark Nelson | Administrateur | Millfield Lane WA11 9GA Haydock International House Merseyside United Kingdom | England | British | Director | 124509390001 | ||||
PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Park Row LS1 5AB Leeds 1 West Yorkshire | 128143250001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluto Bidco Limited | 27 sept. 2018 | Millfield Lane Haydock WA11 9GA Merseyside International House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Dunedin Enterprise Investment Trust Plc | 06 avr. 2016 | Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltaire Court Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Nvm Private Equity Llp | 06 avr. 2016 | 32 Gallowgate NE1 4SN Newcastle Upon Tyne Time Central United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 25 juin 2019 Livré le 05 juil. 2019 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 27 sept. 2018 Livré le 10 oct. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Each chargor charges all its right, title and interest by way of first legal mortgage over all land vested in such chargor and all land acquired by such chargor after the date of the instrument. For more details please refer to the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 sept. 2016 Livré le 03 oct. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets); and. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets) together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 août 2012 Livré le 12 sept. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 avr. 2008 Livré le 16 avr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 avr. 2008 Livré le 10 avr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0