HOST EUROPE NINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOST EUROPE NINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06524111
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOST EUROPE NINE LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe HOST EUROPE NINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOST EUROPE NINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOST EUROPE LIMITED26 févr. 200926 févr. 2009
    HOST EUROPE 123 LIMITED11 juin 200811 juin 2008
    LION BIDCO LTD05 mars 200805 mars 2008

    Quels sont les derniers comptes de HOST EUROPE NINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HOST EUROPE NINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:res re books
    1 pagesLIQ MISC RES

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2012

    11 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 5 Roundwood Avenue Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FF le 10 nov. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 oct. 2011

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Certificat de changement de nom

    Company name changed host europe LIMITED\certificate issued on 21/10/11
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mars 2011

    État du capital au 29 mars 2011

    • Capital: GBP 33,045,364
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    11 pagesMG01

    legacy

    22 pagesMG01

    Nomination de Mr Tobias Mohr en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Mr James Shutler en tant que secrétaire

    4 pagesAP03

    Nomination de Mr Thomas Vollrath en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Mr Patrick Pulvermueller en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rebecca Wotherspoon en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter Dubens en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HOST EUROPE NINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHUTLER, James
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United Kingdom
    British155565350001
    MOHR, Tobias
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd
    Middlesex
    Administrateur
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd
    Middlesex
    United KingdomGermanFinance Manager133846810002
    PULVERMUELLER, Patrick
    Welserstrasse 14
    D-51149 Koln
    Host Europe Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Welserstrasse 14
    D-51149 Koln
    Host Europe Gmbh
    Germany
    GermanyGermanManaging Director155584970001
    VOLLRATH, Thomas
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd
    United Kingdom
    United KingdomGermanGeneral Manager155561550001
    COLE, Matthew
    59 Canonbury Road
    N1 2DG London
    Secrétaire
    59 Canonbury Road
    N1 2DG London
    British126591910001
    WOTHERSPOON, Rebecca Jane
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Secrétaire
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    New Zealander134162710001
    CARTER, David Charles
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Administrateur
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    United KingdomBritishSolicitor142322910001
    COLLINS, Alexander Fiske
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Administrateur
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United KingdomItalianCompany Director135884520001
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Administrateur
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritishCompany Director153016810001
    JOSEPH, Mark William
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Administrateur
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director72405460001
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Administrateur
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    BritishCompany Director67037910004
    TILL, David John
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Administrateur
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director133593570001

    HOST EUROPE NINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Share pledge agreement
    Créé le 11 nov. 2010
    Livré le 30 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Grant of pledges the pledgor granted to the pledgees a pledge over the present shares all additional shares in the companhy which the pledgor may by capital increase or otherwise and irrespective of their nominal value or splitting acquired in the future and collectively with the pledged shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Accession deed
    Créé le 11 nov. 2010
    Livré le 18 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each and present member of the group to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 18 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security purpose expansion agreement executed out side the united kingdom over property situated there
    Créé le 09 sept. 2009
    Livré le 25 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The original share pledge agreement 1 shall continue in full force and effect subject to the amendments made by the agreement see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Pledgee)
    Transactions
    • 25 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share pledge agreement
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 15 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the present shares the future shares all ancillary rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Oakley Capital Limited (The Pledgee)
    Transactions
    • 15 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share pledge agreement
    Créé le 02 avr. 2008
    Livré le 15 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its shares, all additional future shares, all present and future rights of the pledged shares, the dividends. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Pledgee)
    Transactions
    • 15 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2008
    Livré le 12 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Oakley Capital Limited as Security Agent for the Noteholders (The Note Security Agent)
    Transactions
    • 12 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group debenture
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 22 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 22 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    HOST EUROPE NINE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 oct. 2011Commencement of winding up
    22 avr. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0