WELLNESS DORMANT 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWELLNESS DORMANT 1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06526439
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WELLNESS DORMANT 1 LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WELLNESS DORMANT 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WELLNESS DORMANT 1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DORSET CEREALS ACQUISITION HOLDING LIMITED12 mars 200812 mars 2008
    JUBILEE ACQUISITION HOLDING LIMITED06 mars 200806 mars 2008

    Quels sont les derniers comptes de WELLNESS DORMANT 1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour WELLNESS DORMANT 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    13 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 3000 Hillswood Business Park Hillswood Drive Chertsey England KT16 0RS à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 28 juin 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 juin 2016

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mars 2016

    État du capital au 09 mars 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital après une attribution d'actions au 20 déc. 2015

    • Capital: GBP 18,475,000.00
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Bonus shares, dividends 20/12/2015
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    21 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    État du capital au 21 déc. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    15 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark John Lane le 05 mars 2015

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mars 2015

    État du capital au 11 mars 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Certificat de changement de nom

    Company name changed dorset cereals acquisition holding LIMITED\certificate issued on 03/10/14
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WELLNESS DORMANT 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Secrétaire
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British151310390001
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish132183700002
    MAGEE, Gerard Vincent
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IrelandIrish151272980001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    Underwood Street
    N1 7JQ London
    6-8
    Secrétaire
    Underwood Street
    N1 7JQ London
    6-8
    128406300001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish164624980001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    Underwood Street
    N1 7JQ London
    6-8
    Administrateur
    Underwood Street
    N1 7JQ London
    6-8
    128406310001

    WELLNESS DORMANT 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A supplemental deed
    Créé le 13 janv. 2010
    Livré le 14 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 14 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Cmposite debenture
    Créé le 24 déc. 2009
    Livré le 08 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 08 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security accession agreement
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 27 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties)
    Transactions
    • 27 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    WELLNESS DORMANT 1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 juin 2016Commencement of winding up
    05 mars 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0