PELIPAN SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPELIPAN SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06541622
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PELIPAN SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PELIPAN SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Cvr Global Llp Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PELIPAN SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REGENERSIS RECOMMERCE LIMITED31 janv. 201331 janv. 2013
    REGENERSIS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED12 avr. 200812 avr. 2008
    PIMCO 2759 LIMITED20 mars 200820 mars 2008

    Quels sont les derniers comptes de PELIPAN SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PELIPAN SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 nov. 2017

    13 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR United Kingdom à C/O Cvr Global Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD le 20 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 nov. 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE à 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR le 20 déc. 2016

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Lorraine Young Company Secretaries Limited en tant que secrétaire le 18 mai 2016

    1 pagesTM02

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 mai 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mars 2016

    État du capital au 30 mars 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nomination de Mr Thorsten Thorsten Schauer en tant qu'administrateur le 08 juin 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jog Dhody en tant que directeur le 08 juin 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jog Dhody le 23 juin 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Simon Julian Harper en tant que directeur le 05 mai 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mars 2015

    État du capital au 25 mars 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jog Dhody le 01 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 4Th Floor 32 Wigmore Street London W1U 2RP à 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE le 10 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Dr Simon Julian Harper en tant qu'administrateur le 31 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Pritpal Singh Matharu en tant que directeur le 31 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Prism Cosec Limited en tant que secrétaire le 01 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Lorraine Young Company Secretaries Limited en tant que secrétaire le 01 oct. 2014

    2 pagesAP04

    Qui sont les dirigeants de PELIPAN SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCHAUER, Thorsten
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    C/O Cvr Global Llp Town Wall House
    Essex
    Administrateur
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    C/O Cvr Global Llp Town Wall House
    Essex
    United KingdomGermanManaging Director192832850001
    TEMPLE, John Nicholas
    18 Highfield Road
    Westmoors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    18 Highfield Road
    Westmoors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Other97983200001
    WEATHERALL, Sally
    Old Witney Road
    Eynsham
    OX29 4BD Witney
    4 Elm Place
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Old Witney Road
    Eynsham
    OX29 4BD Witney
    4 Elm Place
    Oxfordshire
    152389800001
    LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07873246
    165261700001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    PRISM COSEC LIMITED
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Secrétaire
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05533248
    116519070002
    DHODY, Jog
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant104269910005
    HARPER, Simon Julian
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer108485480003
    KELHAM, David William
    Old Witney Road
    Eynsham
    OX29 4BD Witney
    4 Elm Place
    Oxfordshire
    Administrateur
    Old Witney Road
    Eynsham
    OX29 4BD Witney
    4 Elm Place
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    LEE, Andrew Stephen
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    Administrateur
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director159105430001
    MATHARU, Pritpal Singh
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director185333180001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector71396660002
    TANSINI, Sergio
    Old Witney Road
    Eynsham
    OX29 4BD Witney
    4 Elm Place
    Oxfordshire
    Administrateur
    Old Witney Road
    Eynsham
    OX29 4BD Witney
    4 Elm Place
    Oxfordshire
    ScotlandItalianManaging Director106858140001
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    Administrateur
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector151756520001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    PELIPAN SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed
    Créé le 12 juin 2008
    Livré le 01 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V. as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    PELIPAN SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 nov. 2016Commencement of winding up
    26 déc. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    practitioner
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp New Fetter Place West
    55 Fetter Lane
    EC4A 1AA London
    practitioner
    Cvr Global Llp New Fetter Place West
    55 Fetter Lane
    EC4A 1AA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0