JAEGER LONDON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJAEGER LONDON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06587828
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JAEGER LONDON LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JAEGER LONDON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o ALIXPARTNERS
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JAEGER LONDON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JL NEWCO LIMITED08 mai 200808 mai 2008

    Quels sont les derniers comptes de JAEGER LONDON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 févr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour JAEGER LONDON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    17 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    34 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    47 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    9 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    4 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    72 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    4 pagesAM01

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor, the White Building, 11 Evesham Street London W11 4AJ United Kingdom à C/O Alixpartners the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB le 25 avr. 2017

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard Mathieu Leighton en tant que directeur le 30 mars 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Christopher Pilling en tant que directeur le 30 mars 2017

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Mr Kenneth Charles Pratt en tant qu'administrateur le 21 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 27 févr. 2016

    31 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2016

    État du capital au 12 mai 2016

    • Capital: GBP 4,103,732.6
    SH01

    Cessation de la nomination de Harminder Singh Atwal en tant que directeur le 26 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 57 Broadwick Street London W1F 9QS à 2nd Floor, the White Building, 11 Evesham Street London W11 4AJ le 15 avr. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Christopher Richard Horobin en tant qu'administrateur le 25 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Mathieu Leighton en tant qu'administrateur le 25 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Charles Alexanderson Wright en tant que directeur le 03 mars 2016

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 28 févr. 2015

    26 pagesAA

    Inscription de la charge 065878280008, créée le 14 oct. 2015

    54 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Colin Glen Henry en tant que directeur le 12 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de JAEGER LONDON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    c/o Alixpartners
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Secrétaire
    c/o Alixpartners
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    173990730001
    HOROBIN, Christopher Richard
    c/o Alixpartners
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Administrateur
    c/o Alixpartners
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    United KingdomBritish204157860001
    PRATT, Kenneth Charles
    c/o Alixpartners
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Administrateur
    c/o Alixpartners
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish72306460002
    EDGERTON, Graham John
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Secrétaire
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    British130262670001
    ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish168411280001
    ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish168411280001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    United KingdomBritish149870270004
    ATWAL, Harminder Singh
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    Administrateur
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    United KingdomBritish167976490001
    EARL, Belinda
    57 Broadwick Street
    W1F 9QS London
    Administrateur
    57 Broadwick Street
    W1F 9QS London
    United KingdomBritish97792020001
    EDGERTON, Graham John
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    United KingdomBritish87214070001
    HENRY, Colin Glen
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish185041040002
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish124967710001
    LEIGHTON, Richard Mathieu
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    Administrateur
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    EnglandDutch183503870005
    MACKENZIE, Andrew Macgregor
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    United KingdomBritish38695210004
    PILLING, Simon Christopher
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    Administrateur
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    United KingdomBritish197534740001
    SANDERS, Nicholas Ian Burgess
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    United KingdomBritish83283880002
    TILLMAN, Harold Peter
    37 Sheldon Avenue
    Highgate
    N6 4JP London
    Administrateur
    37 Sheldon Avenue
    Highgate
    N6 4JP London
    United KingdomBritish10751240001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish161343370001
    WILLIAMS, Peter Wodehouse
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish135547730001
    WRIGHT, Thomas Charles Alexanderson
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    Administrateur
    Broadwick Street
    W1F 9QS London
    57
    EnglandBritish177266130001

    JAEGER LONDON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 oct. 2015
    Livré le 16 oct. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Gp Limited, as General Partner of BECAP12 Gp LP, as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transactions
    • 16 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 mars 2014
    Livré le 01 avr. 2014
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Gp Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Security agreement
    Créé le 05 avr. 2013
    Livré le 16 avr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the loan note parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Gp Limited
    Transactions
    • 16 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security agreement
    Créé le 16 avr. 2012
    Livré le 24 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Macsco 40 Limited (Now Known as Becap Jaeger (UK) Limited)
    Transactions
    • 24 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security agreement
    Créé le 13 avr. 2012
    Livré le 24 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Spv 2 Limited
    Transactions
    • 24 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 31 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 12 mai 2010
    Livré le 18 mai 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 12 mai 2010
    Livré le 18 mai 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Accession deed
    Créé le 09 juil. 2008
    Livré le 16 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 16 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    JAEGER LONDON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 avr. 2017Administration started
    23 nov. 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ryan Kevin Grant
    Alix Partners Services Uk Llp
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    practitioner
    Alix Partners Services Uk Llp
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0