ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED

ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06590880
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane
    Appleton
    WA4 4ST Warrington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOTHERWELL BRIDGE LIMITED11 sept. 200811 sept. 2008
    ELYDALE LIMITED13 mai 200813 mai 2008

    Quels sont les derniers comptes de ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mai 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au06 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation20 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au06 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2023

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Paul Gilmore en tant qu'administrateur le 13 juin 2023

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe Goldthorpe Rotherham S63 0JF England à 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton Warrington WA4 4st le 13 juin 2023

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 août 2022

    34 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Fitzsimons en tant que directeur le 31 août 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2021

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2020

    38 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 juin 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes annuels établis au 31 août 2019

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Fitzsimmons le 08 juil. 2019

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Padraig Somers en tant qu'administrateur le 08 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Fitzsimmons en tant qu'administrateur le 08 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Angus Hicks en tant que directeur le 08 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 août 2018

    32 pagesAA

    Cessation de la nomination de Cape Admin 1 Limited en tant que directeur le 22 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jane Victoria Atkinson en tant que directeur le 22 mai 2019

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Angus Hicks le 04 févr. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cape Admin 1 Limited le 04 févr. 2019

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Angus Hicks le 04 févr. 2019

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GILMORE, Jonathan Paul
    Barleycastle Lane
    Appleton
    WA4 4ST Warrington
    6-7 Lyncastle Way
    England
    Administrateur
    Barleycastle Lane
    Appleton
    WA4 4ST Warrington
    6-7 Lyncastle Way
    England
    EnglandBritishDirector263362040001
    SOMERS, Padraig
    Island Ganniv
    Greenville
    Listowel
    3
    Co. Kerry
    Ireland
    Administrateur
    Island Ganniv
    Greenville
    Listowel
    3
    Co. Kerry
    Ireland
    IrelandIrishDirector259818620001
    WALSH, John Anthony Meade
    Barleycastle Lane
    Appleton
    WA4 4ST Warrington
    6-7 Lyncastle Way
    England
    Administrateur
    Barleycastle Lane
    Appleton
    WA4 4ST Warrington
    6-7 Lyncastle Way
    England
    United KingdomBritishUk Finance Director238138720001
    ALLAN, Richard
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Secrétaire
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    British186071180001
    HAMILTON, Robert Herd
    82 Manse Road
    ML1 2PT Motherwell
    Secrétaire
    82 Manse Road
    ML1 2PT Motherwell
    BritishDirector647140001
    MERCER, Paul Andrew
    Villa 1 Gate 1354
    Road 7520
    Janabiyah 575
    Kingdom Of Bahrain
    Secrétaire
    Villa 1 Gate 1354
    Road 7520
    Janabiyah 575
    Kingdom Of Bahrain
    BritishDirector104845840001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    Secrétaire
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    130353650001
    ALLAN, Richard Friend
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Administrateur
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director183409640001
    ATKINSON, Jane Victoria
    Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2, Fields End Business Park
    Rotherham
    England
    Administrateur
    Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2, Fields End Business Park
    Rotherham
    England
    EnglandBritishDirector242910000001
    FITZSIMONS, David
    Chapterhouse Close
    CH65 4EP Ellesmere Port
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chapterhouse Close
    CH65 4EP Ellesmere Port
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector260284850003
    GEORGE, Victoria Anne
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Administrateur
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Tax Advisor134024500001
    GROVER, John
    South Town Road
    Medstead
    GU34 5ES Hants
    Rowan House
    United Kingdom
    Administrateur
    South Town Road
    Medstead
    GU34 5ES Hants
    Rowan House
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director213497560001
    HAMILTON, Robert Herd
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton, Middlesex
    Cape Intermediate Holdings Limited
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton, Middlesex
    Cape Intermediate Holdings Limited
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director647140001
    HAMILTON, Robert Herd
    82 Manse Road
    ML1 2PT Motherwell
    Administrateur
    82 Manse Road
    ML1 2PT Motherwell
    United KingdomBritishDirector647140001
    HAYES, Michael Hugh
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    Administrateur
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritishDirector50729030001
    HICKS, Simon Angus
    Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2, Fields End Business Park
    Rotherham
    England
    Administrateur
    Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2, Fields End Business Park
    Rotherham
    England
    EnglandBritishCompany Director189093640001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Administrateur
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    MERCER, Paul Andrew
    Villa 1 Gate 1354
    Road 7520
    Janabiyah 575
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    Villa 1 Gate 1354
    Road 7520
    Janabiyah 575
    Kingdom Of Bahrain
    BahrainBritishDirector104845840001
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Administrateur
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor162620820001
    SAEED, Ahmad
    Road 740
    Block 507
    Manama
    Villa 2402
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    Road 740
    Block 507
    Manama
    Villa 2402
    Kingdom Of Bahrain
    BahrainPakistaniDirector131486840001
    SCOTT, Mark Jason
    Brindley Way
    Wakefield 41 Industrial Park
    WF2 0XQ Wakefield
    Unit 2b
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Brindley Way
    Wakefield 41 Industrial Park
    WF2 0XQ Wakefield
    Unit 2b
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director205880020001
    SHARKEY, Colin Stuart
    Motherwell
    ML1 3NP Motherwell
    Motherwell Bridge Works
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Motherwell
    ML1 3NP Motherwell
    Motherwell Bridge Works
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritishFinancial Director127225940003
    TYRRELL, Ronan Paul
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Administrateur
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    United KingdomIrishChartered Accountant235555870001
    WARD, Russell
    15 Beech Grove
    Hayling Island
    PO11 9DP Hampshire
    Tourner Lodge
    England
    England
    Administrateur
    15 Beech Grove
    Hayling Island
    PO11 9DP Hampshire
    Tourner Lodge
    England
    England
    EnglandEnglishEngineer227776960001
    WILLIAMS, Lloyd
    Villa 6, Gate 1221, Road 2941
    Al Markh 529
    Bahrain
    Administrateur
    Villa 6, Gate 1221, Road 2941
    Al Markh 529
    Bahrain
    BahrainBritishDirector131132990001
    CAPE ADMIN 1 LIMITED
    Fields End Business Park
    Davey Road
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2
    Rotherham
    United Kingdom
    Administrateur
    Fields End Business Park
    Davey Road
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2
    Rotherham
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement9277026
    194285370001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    06 avr. 2016
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3299544
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Shares pledge
    Créé le 20 déc. 2012
    Livré le 03 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The charged assets meaning the pledged securities being 7,900,000 ordinary shares in mb engineering services limited together with all other shares held from time to time by or for the pledgor see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Pledge over deposit
    Créé le 27 oct. 2011
    Livré le 09 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All amounts now and in the future credited to either of the accounts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 09 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Shares pledge
    Créé le 31 oct. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholder security trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pledges and assigns the charged assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Michael Hugh Hayes and Robert Herd Hamilton Acting Jointly as Agent and Security Trustees for Themselves and for Each of the Noteholders
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second ranking debenture
    Créé le 31 oct. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholder security trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Second fixed charge all of its rights to,and title and interest in the real property all plant machinery vehicles equipment and chattels all debts all account proceeds second floating charge all its rights to and title and interest in the whole of its property assets rights and revenues see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Michael Hugh Hayes and Robert Herd Hamilton Acting Jointly as Agent and Security Trustees for Themselves and for Each of the Noteholders
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share pledge
    Créé le 12 juin 2008
    Livré le 02 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pledges and assigns the charged assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 juin 2008
    Livré le 25 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties, or any of them, on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 déc. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 18 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0