ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06590880 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?
Adresse du siège social | 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton WA4 4ST Warrington England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 août 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mai 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 juil. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 juil. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2023 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jonathan Paul Gilmore en tant qu'administrateur le 13 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe Goldthorpe Rotherham S63 0JF England à 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton Warrington WA4 4st le 13 juin 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2022 | 34 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Fitzsimons en tant que directeur le 31 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2021 | 35 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2020 | 38 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2019 | 34 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Fitzsimmons le 08 juil. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Padraig Somers en tant qu'administrateur le 08 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Fitzsimmons en tant qu'administrateur le 08 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Angus Hicks en tant que directeur le 08 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2018 | 32 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Cape Admin 1 Limited en tant que directeur le 22 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jane Victoria Atkinson en tant que directeur le 22 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Angus Hicks le 04 févr. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Cape Admin 1 Limited le 04 févr. 2019 | 1 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Angus Hicks le 04 févr. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILMORE, Jonathan Paul | Administrateur | Barleycastle Lane Appleton WA4 4ST Warrington 6-7 Lyncastle Way England | England | British | Director | 263362040001 | ||||||||
SOMERS, Padraig | Administrateur | Island Ganniv Greenville Listowel 3 Co. Kerry Ireland | Ireland | Irish | Director | 259818620001 | ||||||||
WALSH, John Anthony Meade | Administrateur | Barleycastle Lane Appleton WA4 4ST Warrington 6-7 Lyncastle Way England | United Kingdom | British | Uk Finance Director | 238138720001 | ||||||||
ALLAN, Richard | Secrétaire | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | British | 186071180001 | ||||||||||
HAMILTON, Robert Herd | Secrétaire | 82 Manse Road ML1 2PT Motherwell | British | Director | 647140001 | |||||||||
MERCER, Paul Andrew | Secrétaire | Villa 1 Gate 1354 Road 7520 Janabiyah 575 Kingdom Of Bahrain | British | Director | 104845840001 | |||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Upper Bank Street E14 5JJ London 10 | 130353650001 | |||||||||||
ALLAN, Richard Friend | Administrateur | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | England | British | Company Director | 183409640001 | ||||||||
ATKINSON, Jane Victoria | Administrateur | Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Building 2, Fields End Business Park Rotherham England | England | British | Director | 242910000001 | ||||||||
FITZSIMONS, David | Administrateur | Chapterhouse Close CH65 4EP Ellesmere Port 1 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 260284850003 | ||||||||
GEORGE, Victoria Anne | Administrateur | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | United Kingdom | British | Chartered Tax Advisor | 134024500001 | ||||||||
GROVER, John | Administrateur | South Town Road Medstead GU34 5ES Hants Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 213497560001 | ||||||||
HAMILTON, Robert Herd | Administrateur | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton, Middlesex Cape Intermediate Holdings Limited England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 647140001 | ||||||||
HAMILTON, Robert Herd | Administrateur | 82 Manse Road ML1 2PT Motherwell | United Kingdom | British | Director | 647140001 | ||||||||
HAYES, Michael Hugh | Administrateur | Wenlock Mounthooly TD8 6TJ Jedburgh Roxburghshire | Scotland | British | Director | 50729030001 | ||||||||
HICKS, Simon Angus | Administrateur | Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Building 2, Fields End Business Park Rotherham England | England | British | Company Director | 189093640001 | ||||||||
LEVY, Adrian Joseph Morris | Administrateur | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | United Kingdom | British | Solicitor | 147682410001 | ||||||||
MERCER, Paul Andrew | Administrateur | Villa 1 Gate 1354 Road 7520 Janabiyah 575 Kingdom Of Bahrain | Bahrain | British | Director | 104845840001 | ||||||||
PUDGE, David John | Administrateur | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | United Kingdom | British | Solicitor | 162620820001 | ||||||||
SAEED, Ahmad | Administrateur | Road 740 Block 507 Manama Villa 2402 Kingdom Of Bahrain | Bahrain | Pakistani | Director | 131486840001 | ||||||||
SCOTT, Mark Jason | Administrateur | Brindley Way Wakefield 41 Industrial Park WF2 0XQ Wakefield Unit 2b West Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 205880020001 | ||||||||
SHARKEY, Colin Stuart | Administrateur | Motherwell ML1 3NP Motherwell Motherwell Bridge Works Scotland Scotland | Scotland | British | Financial Director | 127225940003 | ||||||||
TYRRELL, Ronan Paul | Administrateur | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | United Kingdom | Irish | Chartered Accountant | 235555870001 | ||||||||
WARD, Russell | Administrateur | 15 Beech Grove Hayling Island PO11 9DP Hampshire Tourner Lodge England England | England | English | Engineer | 227776960001 | ||||||||
WILLIAMS, Lloyd | Administrateur | Villa 6, Gate 1221, Road 2941 Al Markh 529 Bahrain | Bahrain | British | Director | 131132990001 | ||||||||
CAPE ADMIN 1 LIMITED | Administrateur | Fields End Business Park Davey Road S63 0JF Goldthorpe Building 2 Rotherham United Kingdom |
| 194285370001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Industrial Services Group Limited | 06 avr. 2016 | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ALTRAD MOTHERWELL BRIDGE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Shares pledge | Créé le 20 déc. 2012 Livré le 03 janv. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The charged assets meaning the pledged securities being 7,900,000 ordinary shares in mb engineering services limited together with all other shares held from time to time by or for the pledgor see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Pledge over deposit | Créé le 27 oct. 2011 Livré le 09 nov. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All amounts now and in the future credited to either of the accounts see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Shares pledge | Créé le 31 oct. 2008 Livré le 19 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the noteholder security trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Pledges and assigns the charged assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Second ranking debenture | Créé le 31 oct. 2008 Livré le 19 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the noteholder security trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Second fixed charge all of its rights to,and title and interest in the real property all plant machinery vehicles equipment and chattels all debts all account proceeds second floating charge all its rights to and title and interest in the whole of its property assets rights and revenues see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share pledge | Créé le 12 juin 2008 Livré le 02 juil. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Pledges and assigns the charged assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 12 juin 2008 Livré le 25 juin 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties, or any of them, on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0