APEX COLLECTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAPEX COLLECTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06613933
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VERONA ASSET FINANCE LIMITED06 juin 200806 juin 2008

    Quels sont les derniers comptes de APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Andrew Graham en tant qu'administrateur le 30 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Barrie Morris en tant que directeur le 30 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Derek George Usher en tant que directeur le 31 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Jenkins en tant qu'administrateur le 31 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Barrie Morris le 23 oct. 2020

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Barrie Morris en tant qu'administrateur le 12 mai 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Anthony Buick en tant que directeur le 12 mai 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Derek George Usher en tant qu'administrateur le 23 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kenneth John Stannard en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Buckingham Road Brackley Northamptonshire NN13 7DN United Kingdom à 1 Kings Hill Avenue Kings Hill West Malling ME19 4UA le 05 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Charlotte Taggart en tant que secrétaire le 29 mars 2019

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Sarah Whiteley en tant que secrétaire le 29 mars 2019

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    3 pagesAA

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITELEY, Sarah
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    Secrétaire
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    256923450001
    GRAHAM, Jonathan Andrew
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    EnglandBritish79267560001
    JENKINS, Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    EnglandBritish120733130002
    CLYNE, Neil
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    Secrétaire
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    British159277390001
    RANDALL, John David
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    Secrétaire
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    171098370001
    TAGGART, Charlotte
    10-15 Queen Street
    EC4N 1TX London
    Aldermary House
    England
    England
    Secrétaire
    10-15 Queen Street
    EC4N 1TX London
    Aldermary House
    England
    England
    193781790001
    WELLINGHOFF, Willem Pieter
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    Secrétaire
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    174964250001
    GLOBAL SECURITISATION SERVICES LIMITED
    Reigate Hill
    RH2 9RN Reigate
    Rock Farm
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Reigate Hill
    RH2 9RN Reigate
    Rock Farm
    Surrey
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6613933
    126695650001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Secrétaire
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    130988140001
    BUICK, Craig Anthony
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    United KingdomBritish,Australian204155120001
    CLYNE, Neil
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    Administrateur
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    EnglandBritish126151310002
    CRAWFORD, Glen Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish178683410001
    FLEMING, Shirley Jane
    86 Colonel Stephens Way
    TN30 6EZ Tenterden
    Kent
    Administrateur
    86 Colonel Stephens Way
    TN30 6EZ Tenterden
    Kent
    EnglandBritish57633520004
    MORRIS, Jonathan Barrie
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    EnglandBritish262461330002
    MOUND, Stephen Neil
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    Administrateur
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    EnglandBritish132057230001
    RANDALL, John David
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish57217680002
    ROSS-ROBERTS, Christopher Michael David
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    Administrateur
    Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House 27
    Warwickshire
    EnglandBritish170918350001
    STANNARD, Kenneth John
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish103402250002
    TOWNSON, Neil David
    53 Havering Drive
    RM1 4BH Romford
    Essex
    Administrateur
    53 Havering Drive
    RM1 4BH Romford
    Essex
    United KingdomBritish46320530001
    USHER, Derek George
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    England
    EnglandBritish194636730001
    GLOBAL SECURITISATION SERVICES LIMITED
    Fort Lane
    Reigate Hill
    RH2 9RN Reigate
    Rock Farm
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Fort Lane
    Reigate Hill
    RH2 9RN Reigate
    Rock Farm
    Surrey
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6613933
    126695650001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    130988150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur APEX COLLECTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Apex Credit Management Limited
    Buckingham Road
    NN13 7DN Brackley
    Buckingham House
    England
    30 juin 2016
    Buckingham Road
    NN13 7DN Brackley
    Buckingham House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement3967099
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    APEX COLLECTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 21 févr. 2012
    Livré le 28 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any hedging bank or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 28 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 14 juil. 2011
    Livré le 18 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any hedging bank or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 18 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 06 avr. 2011
    Livré le 13 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any hedging bank or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 13 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Spv deed of charge
    Créé le 27 juin 2008
    Livré le 07 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title, interest and benefit present and future in, to and under the finance documents and all other contracts, agreements, deeds and documents, present and future, to which the company is or may become party see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch in Its Capacity as Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 07 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 05 déc. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 05 déc. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 mars 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0