DE FACTO 1639 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDE FACTO 1639 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06619029
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DE FACTO 1639 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DE FACTO 1639 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DE FACTO 1639 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    L.K. BENNETT GROUP LIMITED30 juin 200830 juin 2008
    DE FACTO 1639 LIMITED13 juin 200813 juin 2008

    Quels sont les derniers comptes de DE FACTO 1639 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour DE FACTO 1639 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 mai 2019

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 mai 2018

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:resolution re: appointment of liquidators
    1 pagesLIQ MISC

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 31 mai 2017

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de Rivington House 82 Great Eastern Street London EC2A 3JF à 3 Hardman Street Manchester M3 3HF le 15 juin 2017

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    38 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Robert Bensoussan en tant que directeur le 29 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Patrick John Warren Woodall en tant que directeur le 28 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Hugh Philip Lenon en tant que directeur le 28 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Burns en tant que directeur le 28 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name19 avr. 2017

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Linda Kristin Bennett en tant que directeur le 06 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 13 juin 2016

    24 pagesRP04AR01

    Déclaration annuelle

    13 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 févr. 2017

    État du capital au 07 févr. 2017

    • Capital: GBP 16,009,800
    SH01

    Nomination de Mr Michael Hitchcock en tant que secrétaire le 13 sept. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Alison Egan en tant que directeur le 13 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alison Egan en tant que secrétaire le 13 sept. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Darren Lee Topp en tant qu'administrateur le 13 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael Paul Hitchcock en tant qu'administrateur le 13 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 01 août 2015

    32 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juil. 2015

    État du capital au 02 juil. 2015

    • Capital: GBP 16,009,800
    SH01

    Qui sont les dirigeants de DE FACTO 1639 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HITCHCOCK, Michael
    Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    Secrétaire
    Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    215842640001
    HITCHCOCK, Michael Paul
    Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    Administrateur
    Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    EnglandBritishDirector44917990002
    TOPP, Darren Lee
    Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    Administrateur
    Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    United KingdomBritishDirector208060210001
    EGAN, Alison
    Broad Hinton Road
    SW4 0LU Clapham
    22a
    Secrétaire
    Broad Hinton Road
    SW4 0LU Clapham
    22a
    BritishDirector138916940001
    GHINN, Julian
    16 North View Crescent
    KT18 5UR Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    16 North View Crescent
    KT18 5UR Epsom
    Surrey
    BritishFinance Director56414290002
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    Snow Hill
    EC1A 2AL London
    10
    Uk
    Secrétaire
    Snow Hill
    EC1A 2AL London
    10
    Uk
    127984580001
    BENNETT, Linda Kristin
    3 Fitzroy Square
    W1T 5HG London
    Administrateur
    3 Fitzroy Square
    W1T 5HG London
    United KingdomBritishDirector122708920001
    BENSOUSSAN, Robert
    8 Bramerton Street
    SW3 5JX London
    Administrateur
    8 Bramerton Street
    SW3 5JX London
    United KingdomSpanishDirector79906360003
    BURNS, David
    32 Festing Road
    SW15 1LP London
    Administrateur
    32 Festing Road
    SW15 1LP London
    EnglandBritishDirector67605640001
    EGAN, Alison
    Broad Hinton Road
    SW4 0LU Clapham
    22a
    Administrateur
    Broad Hinton Road
    SW4 0LU Clapham
    22a
    EnglandBritishDirector138916940001
    GHINN, Julian
    16 North View Crescent
    KT18 5UR Epsom
    Surrey
    Administrateur
    16 North View Crescent
    KT18 5UR Epsom
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director56414290002
    LENON, Hugh Philip
    82 Great Eastern Street
    EC2A 3JF London
    Rivington House
    Administrateur
    82 Great Eastern Street
    EC2A 3JF London
    Rivington House
    EnglandBritishNone82706470002
    MCDONALD, Margaret
    Paultons Street
    SW3 5DR London
    11
    Administrateur
    Paultons Street
    SW3 5DR London
    11
    IrishManaging Director135873400001
    VILKAULS, Erica
    Aldbury
    HP23 5RX Tring
    The Standings, Stocks Farm,
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Aldbury
    HP23 5RX Tring
    The Standings, Stocks Farm,
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishRetail139874590001
    WOODALL, Patrick John Warren
    82 Great Eastern Street
    EC2A 3JF London
    Rivington House
    Administrateur
    82 Great Eastern Street
    EC2A 3JF London
    Rivington House
    United KingdomBritishCompany Director187368550001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    Snow Hill
    EC1A 2AL London
    10
    Uk
    Administrateur
    Snow Hill
    EC1A 2AL London
    10
    Uk
    127984590001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    Snow Hill
    EC1A 2AL London
    10
    Uk
    Administrateur
    Snow Hill
    EC1A 2AL London
    10
    Uk
    127984580001

    DE FACTO 1639 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Group debenture
    Créé le 18 mai 2012
    Livré le 25 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 25 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Key-man policies assignment
    Créé le 29 juin 2009
    Livré le 15 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Key man policies life assured margaret mcdonald £1,000,000 legal and general pol no. 013270588-0 3 years all its rights titles and interests see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited (In Its Capacity as a Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Key-man policies assignment
    Créé le 16 sept. 2008
    Livré le 24 sept. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest from time to time in and to the proceeds of the policies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited (In Its Capacity as a Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 24 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 18 juil. 2008
    Livré le 31 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 31 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    DE FACTO 1639 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 mai 2017Commencement of winding up
    12 mars 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lindsey J Cooper
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    practitioner
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Christopher Ratten
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    practitioner
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0