ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED

ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06623768
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Centrix House
    Crow Lane East
    WA12 9UY Newton Le Willows
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ONEDIN (NOMINEES) LIMITED07 juil. 200807 juil. 2008
    PIMCO 2789 LIMITED18 juin 200818 juin 2008

    Quels sont les derniers comptes de ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 août 2015

    État du capital au 21 août 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Malcolm William Jackson en tant que directeur le 19 déc. 2014

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 août 2014

    État du capital au 21 août 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Isabel Anne Mulroy en tant que directeur le 18 févr. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juil. 2013

    État du capital au 23 juil. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Isabel Anne Mulroy en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Trevor Waggett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Nomination de Trevor John Waggett en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Neil Graham en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Cramond en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Malcolm Page en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed onedin (nominees) LIMITED\certificate issued on 09/07/09
    3 pagesCERTNM

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    395

    Qui sont les dirigeants de ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Secrétaire
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    British62603060001
    DOWNES, John Alfred
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish59635480003
    GRAHAM, Neil
    Goldcrest Way Newburn
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Goldcrest Way Newburn
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish157234940001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    CRAMOND, David John
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    Administrateur
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    United KingdomBritish135860150001
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Administrateur
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    United KingdomBritish62603060001
    MULROY, Isabel Anne
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    Administrateur
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    UkBritish170524310001
    PAGE, Malcolm Douglas
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish112804370001
    WAGGETT, Trevor John
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    EnglandBritish104786440001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement: agency c loan notes
    Créé le 31 mars 2009
    Livré le 06 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • One Northeast (The Agency)
    Transactions
    • 06 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement: b loan notes
    Créé le 31 mars 2009
    Livré le 06 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northeast One (The Agency)
    Transactions
    • 06 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement: agency a loan notes
    Créé le 31 mars 2009
    Livré le 06 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • One Northeast (The Agency)
    Transactions
    • 06 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement psp a loan notes
    Créé le 31 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Langtree Northeast Limited (Psp)
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement psp c loan notes
    Créé le 31 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Langtree Northeast Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 avr. 2009

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0