BAKKAVOR ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAKKAVOR ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06664921
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fitzroy Place, 5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Benjamin Jay Waldron en tant que directeur le 31 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Lee Miley en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2023

    20 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Bakkavor West Marsh Road Spalding Lincolnshire PE11 2BB England à Fitzroy Place, 5th Floor 8 Mortimer Street London W1T 3JJ le 09 févr. 2024

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Agust Gudmundsson en tant que directeur le 01 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Michael Edwards en tant qu'administrateur le 01 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 25 déc. 2021

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Lee Paul Dunn en tant que directeur le 11 févr. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Benjamin Jay Waldron en tant qu'administrateur le 01 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 26 déc. 2020

    20 pagesAA

    Nomination de Lee Dunn en tant qu'administrateur le 05 août 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Marc Stephen Archer en tant que directeur le 31 juil. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 28 déc. 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 29 déc. 2018

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mrs Annabel Tagoe-Bannerman en tant que secrétaire le 21 juin 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Simon Witham en tant que secrétaire le 21 juin 2019

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2017

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAGOE-BANNERMAN, Annabel
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place, 5th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place, 5th Floor
    United Kingdom
    259998580001
    EDWARDS, Michael
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    Administrateur
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    EnglandBritishChief Executive Officer277970310001
    MILEY, Lee
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place, 5th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place, 5th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer329004310001
    HOWES, Richard
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    Secrétaire
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    150178220001
    JOWETT, Jonathan David
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Secrétaire
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    BritishSolicitor103825760001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Secrétaire
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    British151217690001
    STANSBURY, John
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    Secrétaire
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    152846890001
    WITHAM, Simon
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    Secrétaire
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    166661350001
    ARCHER, Marc Stephen
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Bakkavor
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Bakkavor
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector158382770001
    DUNN, Lee Paul
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    Administrateur
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    United KingdomBritishGroup Tax Director286115900001
    GUDMUNDSSON, Agust
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    Administrateur
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    United KingdomIcelandicCompany Director79348500026
    HOWES, Richard David
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    Administrateur
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director118715250001
    WALDRON, Benjamin Jay
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place 5th Floor
    England
    Administrateur
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place 5th Floor
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer198102510002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BAKKAVOR ESTATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bakkavor Foods Limited
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    06 août 2017
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement01060806
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Bakkavor Finance (3) Limited
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    06 avr. 2016
    5th Floor
    8 Mortimer Street
    W1T 3JJ London
    Fitzroy Place
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies
    Numéro d'enregistrement7501700
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BAKKAVOR ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 mars 2017
    Livré le 23 mars 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 23 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 avr. 2015
    Livré le 10 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole those subjects comprising land to the north side of the A904, carriden industrial estate, bo'ness t/no's WLN4402 and WLN29761.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 10 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 mars 2015
    Livré le 08 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Nythe watercress beds bishops sutton alresford t/no HP589847 plot 10 antelope way barton upon humber t/no HS184383 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 mars 2015
    Livré le 08 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 08 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 juin 2013
    Livré le 20 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land to the north side of the A904, carriden industrial estate, bo'ness t/no's WLN4402 and WLN297761. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 20 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2013
    Livré le 19 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    UK trademark registration no 2222111, UK trademark registration no 2226728 and UK trademark registration no 2295308 see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2013
    Livré le 18 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Property known as nythe watercress beds bishops suttone alresford title no HP589847. Property known as plot 10 antelope way barton upon humber title no HS184383. Land on north side of ardent road antelope way barton upon humber title no HS277463 see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 05 juin 2013
    Livré le 19 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land on the north side of the A904 carriden industrial estate bo`ness t/no WLN4402 WLN29761. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security dated 06/02/11
    Créé le 09 févr. 2011
    Livré le 11 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the charging companies to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects comprising land to the north side of the A904 carriden industrial estate bo'ness t/no. WLN4402 and WLN29761.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 11 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 07 févr. 2011
    Livré le 18 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Nythe watercress beds, bishops sutton, alresford, t/no: HP589847. Plot 5, falklands way, barton upon humber, t/no: HS300607. Plot 10, antelope way, barton upon humber, t/no: HS184383. (For details of further property charged, please refer to the MG01 document) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 18 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 févr. 2011
    Livré le 18 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the charging companies to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 18 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2010
    Livré le 08 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged, please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 08 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 2008
    Livré le 03 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 03 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2008
    • 21 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Standard security
    Créé le 24 sept. 2008
    Livré le 14 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the tenant's interest in the subjects on the north side of the A904 carriden industrial estate bo'ness being 2.9 hectares in measurement under t/no WLN4402 and all and whole the subjects at carridean industrial estate bo'ness t/no WLN29761.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited as Security Agent
    Transactions
    • 14 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0