SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06791531 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AG London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 29 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 27 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Christopher John Morrogh en tant que directeur le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giuseppe Vullo le 13 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de John Marcus Willcock en tant que directeur le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 27 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 25 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 22 pages | AA | ||
Nomination de Mr Giuseppe Vullo en tant qu'administrateur le 19 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Stephen Lauder en tant qu'administrateur le 19 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Donald Armstrong Jordison en tant que directeur le 19 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 42 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Timothy Nicholas Gillbanks en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 22 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher John Morrogh le 18 juil. 2016 | 2 pages | CH01 | ||
Qui sont les dirigeants de SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYE, Alan | Secrétaire | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | British | 21908430001 | ||||||
| LAUDER, Stephen | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | United Kingdom | British | 175361690001 | |||||
| RIGG, James Mark Alexander | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | United Kingdom | British | 67445210002 | |||||
| STONE, Peter William | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | United Kingdom | British | 190502930001 | |||||
| VULLO, Giuseppe | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | United Kingdom | British | 275318110001 | |||||
| SISEC LIMITED | Secrétaire | Holborn Viaduct EC1A 2DY London 21 Cb | 135664300001 | |||||||
| CHALLENOR, Thomas William | Administrateur | 12 Florence Road Ealing W5 3TX London | England | British | 54906450002 | |||||
| DEVINE, John | Administrateur | St. Mary Axe EC3A 8JQ London 60 | England | British | 69742920003 | |||||
| FLEMING, Campbell David | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | United Kingdom | Australian | 147943620001 | |||||
| GILLBANKS, Timothy Nicholas | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | United Kingdom | British | 103964930001 | |||||
| JORDISON, Donald Armstrong | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | England | British | 166312350001 | |||||
| MORROGH, Christopher John | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | England | British | 65250860003 | |||||
| SEYMOUR, Michael John | Administrateur | Holborn Viaduct EC1A 2FG London Atlantic House Uk | United Kingdom | British | 155276330001 | |||||
| WILLCOCK, John Marcus | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place | England | British | 76276580002 | |||||
| LOVITING LIMITED | Administrateur | Holborn Viaduct EC1A 2DY London 21 United Kingdom | 135664330001 | |||||||
| SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED | Administrateur | Holborn Viaduct EC1A 2DY London 21 United Kingdom | 135664310001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle Property Investments Limited | 06 avr. 2016 | 78 Cannon Street EC4N 6AG London Cannon Place England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SACKVILLE SPF IV PROPERTY (GP) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 23 mai 2014 Livré le 06 juin 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 23 mai 2014 Livré le 06 juin 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of confirmation | Créé le 15 juin 2011 Livré le 23 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All present and future limited partnership interest; right to receivables made pursuant to the limited partnership agreement, limited partnership related rights, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of confirmation | Créé le 15 juin 2011 Livré le 23 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All present and future limited partnership interest; right to receivables made pursuant to the limited partnership agreement, limited partnership related rights, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over limited partnership interest | Créé le 22 janv. 2010 Livré le 08 févr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Present and future assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over limited partnership interest | Créé le 18 déc. 2009 Livré le 31 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all present and future limited partnership interest, right to receivables made to it pursuant to the limited partnership agreement and limited partnership related rights, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over limited partnership interest | Créé le 12 août 2009 Livré le 24 août 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the security created under the limited partnership inerest charge full title guarantee fixed charge related rights see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0