HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD

HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06825134
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD ?

    Adresse du siège social
    Holbeche House 437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2023

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2022

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2021

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2020

    10 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2018

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COMERFORD, David Andrew
    The Ridge
    1133 Warwick Road
    B91 3HQ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    The Ridge
    1133 Warwick Road
    B91 3HQ Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish67128980001
    PEARCE, Mervyn Vincent
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    Secrétaire
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    British114724150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr David Andrew Comerford
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    06 avr. 2016
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 déc. 2016
    Livré le 03 janv. 2017
    En cours
    Brève description
    All that the freehold interest in the land and property known as land and buildings on the east side of plowman street, rugby and registered at the land registry with title absolute under title number WK367644 all that the freehold interest in the land and property known as 14 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM667550 all that the freehold interest in the land and property known as 12 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM786469.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Interbay Funding Limited
    Transactions
    • 03 janv. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 déc. 2016
    Livré le 03 janv. 2017
    En cours
    Brève description
    All that the freehold interest in the land and property known as land and buildings on the east side of plowman street, rugby and registered at the land registry with title absolute under title number WK367644 all that the freehold interest in the land and property known as 14 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM667550 all that the freehold interest in the land and property known as 12 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM786469.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Interbay Funding Limited
    Transactions
    • 03 janv. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    Fee agreement second charge
    Créé le 19 août 2011
    Livré le 23 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Plot 2 postal number 1, the rowans atherstone warwickshire, north warwickshire t/no WK455004 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 23 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fee agreement second charge
    Créé le 05 mars 2010
    Livré le 09 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    21 mill road rugby warwickshire t/n WK430355, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 09 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fee agreement second charge
    Créé le 05 mars 2010
    Livré le 09 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    6 plowman street rugby warwickshire t/n WK367644, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 09 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fee agreement second charge
    Créé le 05 mars 2010
    Livré le 06 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    12 little aston road aldridge walsall west midlands t/no WM786469.by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 06 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fee agreement second charge
    Créé le 05 mars 2010
    Livré le 06 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    14 little aston road, aldridge walsall t/no WM667550. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 06 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 05 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 2 postal no 1 the rowans atherstone t/n WK432870 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 05 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    21 mill road rugby t/n WK430355 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 05 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings on the east side of plowman street, rugby, warwickshire t/no WK367644 and any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 05 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 12 & 14 little aston road, aldridge, walsall, west midlands t/no WM786469 ans WM667550 and any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 juil. 2009
    Livré le 16 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0