AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED

AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06849405
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Delphian House 4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Greater Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALLCO 1687 LIMITED17 mars 200917 mars 2009

    Quels sont les derniers comptes de AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital après une attribution d'actions au 18 déc. 2023

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Statuts

    8 pagesMA

    État du capital au 03 oct. 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalise merger reserve 02/10/2023
    RES14
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 02 oct. 2023

    • Capital: GBP 349,996
    3 pagesSH01

    Inscription de la charge 068494050016, créée le 01 sept. 2023

    40 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Asbjørn Lønning en tant que directeur le 17 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Imad Barake en tant qu'administrateur le 17 oct. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    23 pagesAA

    Nomination de Asbjørn Lønning en tant qu'administrateur le 24 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kyle Francis Mcclure en tant que directeur le 31 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 068494050012 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 068494050011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 068494050013 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 068494050014 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 068494050010 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLEN, James Roland Thomas
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United KingdomBritishDirector273489720001
    BARAKE, Imad
    Suite 1450
    77056 Houston, Tx
    3050 Post Oak Blvd.
    United States
    Administrateur
    Suite 1450
    77056 Houston, Tx
    3050 Post Oak Blvd.
    United States
    United StatesAmericanDirector301277210001
    MARX, Janette Bates
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Houston, Tx, UsaAmericanDirector207579820001
    GREGSON, Duncan Alasdair
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Secrétaire
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    BritishDirector120589280001
    ALLEN, James Roland Thomas
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United KingdomBritishDirector273489720001
    BRIANT, Timothy
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United KingdomBritishCompany Director130048920001
    DYMOTT, James Graham
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Houston, Tx, UsaBritishChartered Accountant207584020001
    GREGSON, Duncan Alasdair
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector120589280001
    HALLIWELL, Mark
    Spen Green
    Smallwood
    CW11 0UZ Sandbach
    Noah's Ark Farm
    Cheshire
    Uk
    Administrateur
    Spen Green
    Smallwood
    CW11 0UZ Sandbach
    Noah's Ark Farm
    Cheshire
    Uk
    United KingdomBritishDirector135258940001
    LANGLEY, Ian Michael
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritishChairman17966810014
    LØNNING, Asbjørn
    Forusparken
    4033
    Stavanger
    2
    Norway
    Administrateur
    Forusparken
    4033
    Stavanger
    2
    Norway
    NorwayNorwegianDirector293279680001
    MCCLURE, Kyle Francis
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United StatesAmericanDirector244786490001
    MCPHERSON, Kenneth
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    United KingdomBritishFd224051820001
    SEARLE, Peter William Courtis
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    Administrateur
    4th Floor
    Riverside New Bailey Street
    M3 5FS Manchester
    Delphian House
    Greater Manchester
    EnglandBritishDirector116102520002
    Halliwells Directors Limited
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    3
    Administrateur
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    3
    128832470001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Air Energi Holdings Limited
    Riverside
    New Bailey Street
    M3 5FS Salford
    Delphian House 4th Floor
    England
    06 avr. 2016
    Riverside
    New Bailey Street
    M3 5FS Salford
    Delphian House 4th Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06849455
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    AIR ENERGI INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 sept. 2023
    Livré le 08 sept. 2023
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transactions
    • 08 sept. 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 sept. 2021
    Livré le 01 oct. 2021
    En cours
    Brève description
    Clause 3.3(a) of the debenture creates a fixed charge over all of the rights (as defined in the debenture) which the company now has and all the rights which it obtains at any time in the future in land (as defined in the debenture) and any rights accruing to, derived from or otherwise connected with them.. Clause 3.3(f) of the debenture creates a fixed charge over all of the rights (as defined in the debenture) which the company now has and all the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property (as defined in the debenture) and any rights accruing to, derived from or otherwise connected with them.. Please see the debenture for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transactions
    • 01 oct. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 janv. 2016
    Livré le 28 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 janv. 2016
    Livré le 28 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 janv. 2016
    Livré le 01 févr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transactions
    • 01 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 janv. 2016
    Livré le 26 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust, National Association
    Transactions
    • 26 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 janv. 2016
    Livré le 26 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust, National Association
    Transactions
    • 26 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture dated 5 october 2012 as amended by the amendment deed dated 18 october 2012
    Créé le 05 oct. 2012
    Livré le 22 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including the charged securites, intellectual property, goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited as the Security Agent
    Transactions
    • 22 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 05 oct. 2012
    Livré le 12 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent)
    Transactions
    • 12 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 13 août 2012
    Livré le 23 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ian Michael Langley (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2010
    Livré le 28 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 10 août 2009
    Livré le 21 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Full title gusrantee as continuing security all secured obligations see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ian Michael Langley
    Transactions
    • 21 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 août 2009
    Livré le 21 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee (on behalf of the security beneficiaries) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ian Michael Langley
    Transactions
    • 21 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 août 2009
    Livré le 15 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Zeus Private Equity LLP (The Security Trustee)
    Transactions
    • 15 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 août 2009
    Livré le 15 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Zeus Private Equity LLP (The Security Trustee)
    Transactions
    • 15 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession and charge
    Créé le 10 août 2009
    Livré le 18 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0