HIMOR (RETAIL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHIMOR (RETAIL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06861634
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Carrington Business Park Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONTINENTAL SHELF 464 LIMITED27 mars 200927 mars 2009

    Quels sont les derniers comptes de HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 27 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2017

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Darren Jones en tant que directeur le 02 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Mark Austin Booth en tant qu'administrateur le 16 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Wrigglesworth en tant qu'administrateur le 16 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    20 pagesAA

    Nomination de Mr Darren Jones en tant qu'administrateur le 19 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew John Gee en tant que directeur le 31 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 avr. 2016

    État du capital au 22 avr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    16 pagesAA

    Inscription de la charge 068616340007, créée le 06 août 2015

    8 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de Clarence House Clarence Street Manchester M2 4DW à Carrington Business Park Carrington Business Park, Manchester Road Carrington Manchester M31 4DD le 28 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    AR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 avr. 2015

    État du capital au 22 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew John Gee en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2014

    État du capital au 14 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Centrix House Crow Lane East Newton-Le-Willows Merseyside WA12 9UY England

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées du secrétaire Mark Austin Booth le 13 janv. 2013

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    15 pagesAA

    Inscription de la charge 068616340006

    8 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOOTH, Mark Austin
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Secrétaire
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    British149671990001
    AINSCOUGH, William Francis
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Administrateur
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    United KingdomBritishCompany Director106090700008
    AINSCOUGH, William
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Administrateur
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    United KingdomBritishCompany Director18332250011
    BOOTH, Mark Austin
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Administrateur
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    EnglandBritishCertified Chartered Accountant222490230001
    WRIGGLESWORTH, Paul
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Administrateur
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    EnglandEnglishChartered Surveyor222491090001
    AINSCOUGH, William Francis
    High Barn Farm
    Highmoor Lane, Wrightington
    WN6 9PX Wigan
    Secrétaire
    High Barn Farm
    Highmoor Lane, Wrightington
    WN6 9PX Wigan
    BritishCompany Director106090700006
    MD SECRETARIES LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Secrétaire
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    117456920001
    GEE, Andrew John
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Administrateur
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    EnglandBritishChartered Accountant124531000001
    JONES, Darren
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Administrateur
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    EnglandBritishManaging Director112039530002
    MARTIN, Patrick Tyson
    88 Grandison Road
    Battersea
    SW11 6LN London
    Administrateur
    88 Grandison Road
    Battersea
    SW11 6LN London
    BritishSolicitor50171670003
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Administrateur
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    134980600001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HIMOR (RETAIL) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr William Ainscough
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    06 avr. 2016
    Carrington Business Park, Manchester Road
    Carrington
    M31 4DD Manchester
    Carrington Business Park
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HIMOR (RETAIL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 06 août 2015
    Livré le 11 août 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2013
    Livré le 01 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    Land and buildings on the north east side of ack lane and on the north west side of bramhall lane, south bramhall (land registry title no: GM713592) 8 and 10 ack lane east, bramhall (land registry title no: GM106637) land on the north west side of bramhall lane south, bramhall (land registry title no: GM51768). Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal charge
    Créé le 07 janv. 2013
    Livré le 09 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the east side of station road swinton manchester t/n GM438354 and land lying to the east side of station road swinton manchester t/n GM471358 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 27 juil. 2011
    Livré le 03 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    59 mill street, macclesfield t/no CH221175 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 27 juil. 2011
    Livré le 03 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    72 high street, barnstaple t/no DN401776 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 24 mars 2010
    Livré le 30 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and buildings on the south side of exchange street macclesfield cheshire t/n CH254836, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 24 mars 2010
    Livré le 30 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 81 linthorpe road middlesbrough and 13 whin street middlesbrough t/n TES7126, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0