RMU MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRMU MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06876889
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RMU MANAGEMENT LIMITED ?

    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe RMU MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor Egginton House
    25 - 28 Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de RMU MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour RMU MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de 7th Floor South Artillery House 11-19 Artillery Row London London SW1P 1RT England le 27 mars 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    3 pagesAA

    Nomination de Ms Michelle De Young en tant qu'administrateur le 20 nov. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Henry Soanes en tant que directeur le 20 nov. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sean Ernan Fay en tant que directeur le 20 nov. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julian Robert Archer Spooner en tant que directeur le 08 nov. 2012

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Brandspace Group, Sandfield House Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AR, United Kingdom le 14 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mai 2012

    État du capital au 11 mai 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Paul Henry Soanes en tant qu'administrateur le 13 juin 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Sean Ernan Fay en tant qu'administrateur le 01 juil. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Julian Robert Archer Spooner en tant qu'administrateur le 05 août 2011

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Cobbetts Llp 58 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ le 10 mai 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard Charles Jaques en tant que directeur le 30 juin 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roy Wade en tant que directeur le 09 mai 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephan Michael Hughes en tant que directeur le 12 juil. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Charles Jaques en tant que secrétaire le 30 juin 2011

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    3 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    3 pagesAA

    legacy

    11 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de RMU MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Floor Egginton House
    25 - 28 Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    2nd
    England
    Administrateur
    Floor Egginton House
    25 - 28 Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    2nd
    England
    EnglandBritish140102770001
    JAQUES, Richard Charles
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    British56356980006
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    FAY, Sean Ernan
    Floor
    Artillery House, 11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Brandspace 7th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Artillery House, 11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Brandspace 7th
    United Kingdom
    United KingdomIrish84925400001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    JAQUES, Richard Charles
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish56356980006
    SOANES, Paul Henry
    Floor South
    Artillery House 11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Brandspace 7th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor South
    Artillery House 11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Brandspace 7th
    United Kingdom
    EnglandBritish68377030007
    SPOONER, Julian Robert Archer
    Floor South
    Artillery House, 11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Brandspace 7th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor South
    Artillery House, 11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Brandspace 7th
    United Kingdom
    EnglandBritish117770880001
    WADE, Roy
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    Administrateur
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    British131852890001

    RMU MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 02 nov. 2009
    Livré le 13 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 nov. 2009
    Livré le 13 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 14 juil. 2009
    Livré le 31 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0