BSP REALISATIONS 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBSP REALISATIONS 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06893185
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BSP REALISATIONS 2 LIMITED ?

    • (7032) /

    Où se situe BSP REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BSP REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BARRATTS SHOES PROPERTIES 2 LIMITED30 avr. 200930 avr. 2009

    Quels sont les derniers comptes de BSP REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BSP REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 nov. 2012

    53 pages2.24B
    A1MA1PB4

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 22 nov. 2012

    53 pages2.35B
    A1MA1PBC

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 juin 2012

    56 pages2.24B
    A1CNICO9

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 juin 2012

    56 pages2.24B
    A1CFOWGB

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B
    A1B80BW3

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18
    A12AXERL

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    85 pages2.17B
    A110BKUI

    Cessation de la nomination de Ann Elizabeth Mcgookin en tant que secrétaire le 13 janv. 2012

    1 pagesTM02
    X114W456

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15
    A10XSMG1

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT
    A10XSMG9

    Changement d'adresse du siège social de Bpl House 880 Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 1NW le 20 déc. 2011

    2 pagesAD01
    A0O13GSP

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B
    A0O13GSX

    Cessation de la nomination de Brian David Field en tant que directeur le 07 déc. 2011

    1 pagesTM01
    XK4C3ZVU

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mai 2011

    État du capital au 03 mai 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01
    XHO69TT3

    Modification des coordonnées de l'administrateur Two Years Limited le 30 avr. 2011

    2 pagesCH02
    XHO65TTZ

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Michael Anthony Ziff le 30 avr. 2011

    2 pagesCH01
    XHO68TT2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward Max Ziff le 30 avr. 2011

    2 pagesCH01
    XHO67TT1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Martin Weaving le 30 avr. 2011

    2 pagesCH01
    XHO66TT0

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian David Field le 30 avr. 2011

    2 pagesCH01
    XHO64TTY

    legacy

    7 pagesMG01
    AJBGJTQM

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2010

    14 pagesAA
    LANKNR6M

    legacy

    6 pagesMG01
    AP93NQL9

    Changement d'adresse du siège social de Stylo House Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 0NW le 16 août 2010

    2 pagesAD01
    AQ11NMHS

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    XD1DSK33

    Qui sont les dirigeants de BSP REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WEAVING, John Martin
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director137729810001
    ZIFF, Edward Max
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector2002850001
    ZIFF, Michael Anthony
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector9804810001
    TWO YEARS LIMITED
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    Administrateur
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6808747
    137729950001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Secrétaire
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    British139073520001
    FIELD, Brian David
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 1NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    Administrateur
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 1NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector37141570002

    BSP REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission
    Créé le 27 avr. 2011
    Livré le 30 avr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing to the bank represented by that sum and credit balances means all of them.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2009 and
    Créé le 05 janv. 2011
    Livré le 07 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 20 oct. 2009
    Livré le 23 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 02 août 2009
    Livré le 05 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Arnold Securities Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 août 2009
    Livré le 06 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 août 2009
    Livré le 05 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2009Enregistrement d'une charge (395)

    BSP REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 déc. 2011Administration started
    22 nov. 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    practitioner
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Po Box 810
    EC4A 3WA Athene Place
    66 Shoe Lane London
    practitioner
    Deloitte & Touche Llp
    Po Box 810
    EC4A 3WA Athene Place
    66 Shoe Lane London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0