VIALTUS HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | VIALTUS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06904951 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VIALTUS HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | Daisy House Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Lancashire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VIALTUS HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour VIALTUS HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Keith Muller en tant qu'administrateur le 24 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Robinson Riley en tant que directeur le 24 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Daisy House, Suite 1 Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR à Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR le 15 mai 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2013 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 28 mars 2013
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gareth Kirkwood en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de VIALTUS HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGLENNON, David Lewis | Secrétaire | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | 149406810001 | |||||||
MULLER, Neil Keith | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | Company Director | 252490400001 | ||||
SMITH, Stephen Alan | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 161471940001 | ||||
PORTER, Stewart Charles | Secrétaire | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | Director | 67037910004 | |||||
WOTHERSPOON, Rebecca Jane | Secrétaire | Alexandra House W2 1SF London 6a | New Zealander | 134162710001 | ||||||
DUBENS, Peter Adam Daiches | Administrateur | c/o C/O Oakley Capital Limited Cadogan Gate SW1X 0AS London 3 | Switzerland | British | Director | 153016810001 | ||||
KIRKWOOD, Gareth Robert | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Suite 1 Lancashire | England | British | Company Director | 174056480001 | ||||
PORTER, Stewart Charles | Administrateur | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | Director | 67037910004 | |||||
RILEY, Anthony John | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Suite 1 Lancashire | England | British | Company Director | 89230160001 | ||||
RILEY, Matthew Robinson | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | Director | 178585250001 | ||||
TILL, David John | Administrateur | Cambridge Road TW1 2HL Twickenham 28 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Financier | 133593570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VIALTUS HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Telecoms Limited | 06 avr. 2016 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
VIALTUS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Second supplemental deed | Créé le 13 avr. 2012 Livré le 20 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from a chargor to the finance parties, the bi-lateral ancillary lender and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all assets (and all rights in respect thereof), properties, shares, assignments over the accounts, intellectual property, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental deed relating to a debenture dated 7 june 2010 and | Créé le 02 févr. 2011 Livré le 12 févr. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from a chargor to the finance parties, the bi-lateral ancillary lender and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all assets (and all rights in respect thereof), properties, shares, assignments over the accounts, intellectual property, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 juin 2010 Livré le 10 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from a chargor to the finance parties, the bi-lateral ancillary lender and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 janv. 2010 Livré le 27 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture accession deed | Créé le 09 juin 2009 Livré le 20 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Accession deed to a debenture dated 14 march 2008 and | Créé le 09 juin 2009 Livré le 17 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0