PROCESS COMPONENTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PROCESS COMPONENTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06916722 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PROCESS COMPONENTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Rupert House London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PROCESS COMPONENTS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PROCESS COMPONENTS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 29 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PROCESS COMPONENTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Philip Adrian Clarke en tant qu'administrateur le 03 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Statuts | 7 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David John Spooner en tant que secrétaire le 30 nov. 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Spooner en tant que directeur le 30 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2023 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2023 au 30 sept. 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 16 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 069167220006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Paul Jones en tant que directeur le 14 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Notification de Baker Perkins Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 juil. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Schenck Process Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 juil. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021 | 15 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David John Spooner en tant que secrétaire le 31 mai 2022 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Paul Jones en tant que secrétaire le 31 mai 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Peter Bassett en tant que directeur le 31 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr. Daniel Peter Bassett en tant qu'administrateur le 20 déc. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020 | 22 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr. David John Spooner en tant qu'administrateur le 21 déc. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nicholas Paul Jones en tant que secrétaire le 11 août 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Thomson en tant qu'administrateur le 11 août 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PROCESS COMPONENTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARKE, Philip Adrian | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | England | British | Finance Director | 217703290001 | ||||
THOMSON, Martin | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | England | British | Sales Director | 244704870001 | ||||
JONES, Nicholas Paul | Secrétaire | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | 273108230001 | |||||||
SPOONER, David John | Secrétaire | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | 296715820001 | |||||||
WILD, Hazel Ann | Secrétaire | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | British | 139105850001 | ||||||
TLAW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Tring Road HP22 6PE Wendover 2 Holly Court Buckinghamshire | 138553260001 | |||||||
BASSETT, Daniel Peter, Mr. | Administrateur | Manor Drive PE4 7AP Peterborough Baker Perkins Limited England | United Kingdom | British | Managing Director | 290718060001 | ||||
BESHOFF, James | Administrateur | Leylands Farm Bottom Road HP23 6LJ St. Leonards Dovecote Barn Hertfordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 138266080001 | ||||
GOODWIN, Anthony | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | United Kingdom | British | Managing Director | 139664110001 | ||||
JONES, Nicholas Paul | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | England | British | Finance Director | 72128780004 | ||||
LESLIE, David Alexander Graham | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | England | British | Finance | 180884320001 | ||||
MCKELVEY, James Declan | Administrateur | Bank Street SK11 7AR Macclesfield Graphic House Cheshire | England | Irish | Accountant | 138737980001 | ||||
PALMER, Robin Keith Wynne | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | England | British | Company Director | 124773570001 | ||||
SPOONER, David John | Administrateur | Manor Drive PE4 7AP Peterborough Manor Park England | England | British | Finance Director | 276647800001 | ||||
WALSH, Matthew James | Administrateur | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | England | British | Finance Director | 193140300001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROCESS COMPONENTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker Perkins Holdings Limited | 27 juil. 2022 | Manor Drive PE4 7AP Peterborough Manor Drive England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Schenck Process Uk Limited | 29 sept. 2018 | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Matthew James Walsh | 21 nov. 2017 | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Anthony Goodwin | 06 avr. 2016 | London Road South Poynton SK12 1PQ Stockport Rupert House England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Eso Investments (Pc) Llp | 06 avr. 2016 | Ely Place EC1N 6SN London Audrey House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PROCESS COMPONENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 12 mars 2018 Livré le 15 mars 2018 | Totalement satisfaite | ||
Brève description A fixed and floating charge over all assets. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 août 2016 Livré le 01 sept. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Trade mark number: UK00002506657. Filing date: 17 january 2007. date of entry in register: 29 may 2009. list of goods: class 7, powder processing equipment including centrifugal sifting machines, universal grinding mills, cone mills, kibbler pre-breaker mills. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 juil. 2011 Livré le 11 août 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 juil. 2009 Livré le 30 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti £165,000 | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 juil. 2009 Livré le 14 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 juin 2009 Livré le 02 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0