PRIZE VENTURES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRIZE VENTURES LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 07112083
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRIZE VENTURES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PRIZE VENTURES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O BDO LLP
    5 Temple Square Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRIZE VENTURES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PAYZONE VENTURES LIMITED14 juil. 201014 juil. 2010
    PRIZE VENTURES LIMITED23 déc. 200923 déc. 2009

    Quels sont les derniers comptes de PRIZE VENTURES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2018
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2016

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PRIZE VENTURES LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 déc. 2018
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation06 janv. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 déc. 2017
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour PRIZE VENTURES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2025

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2024

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2023

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2022

    17 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA à 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH le 13 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2021

    13 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Décès d'un liquidateur

    3 pagesLIQ09

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2020

    14 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1QS England à Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA le 30 mai 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 mai 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 071120830005 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 071120830006 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 mars 2018

    3 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Ronald Gagie en tant que directeur le 31 mars 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    19 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Davidson House Gadbrook Park Rudheath Northwich CW9 7TW à Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1QS le 12 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2016

    État du capital au 06 janv. 2016

    • Capital: EUR 3
    SH01

    Qui sont les dirigeants de PRIZE VENTURES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROTHWELL, Julian
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Secrétaire
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    198803580001
    KINGSLAKE GOLDSMITH, Crispin
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Duke Street
    England
    Administrateur
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Duke Street
    England
    EnglandBritish189608100001
    ROTHWELL, Julian Gordon
    First Drift
    Wothorpe
    PE9 3JL Stamford
    St. Martins House
    Lincolnshire
    Administrateur
    First Drift
    Wothorpe
    PE9 3JL Stamford
    St. Martins House
    Lincolnshire
    United KingdomBritish89680610001
    BELL, Nigel
    Monaloe Park
    Cabinteely
    Blackrock
    65
    Co Dublin 18
    Ireland
    Secrétaire
    Monaloe Park
    Cabinteely
    Blackrock
    65
    Co Dublin 18
    Ireland
    British150575080001
    BELL, Nigel
    Monaloe Park
    Cabinteely
    Blackrock
    65
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Monaloe Park
    Cabinteely
    Blackrock
    65
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrish150574820001
    GAGIE, David Ronald
    CV33 9DE Eathorpe
    The Poplars Farmhouse
    Warwickshire
    Administrateur
    CV33 9DE Eathorpe
    The Poplars Farmhouse
    Warwickshire
    EnglandBritish116900490004
    GIBBINS, Julian, Mr.
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    Administrateur
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    United KingdomEnglish146462140001
    KAUL, Arun
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    Administrateur
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    United KingdomSwedish111697450001
    KENNEDY, Iain Alexander
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    97 Lauderdale Mansions
    Administrateur
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    97 Lauderdale Mansions
    United KingdomBritish59809080008
    LOGAN-MOLL, Emmanuel
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    Administrateur
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    EnglandFrench180204170001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    Dublin
    8
    6
    Ireland
    Administrateur
    Beechwood Road
    Ranelagh
    Dublin
    8
    6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    SCOTT, Robert Avisson
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    Uk
    Administrateur
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    Uk
    EnglandBritish,Australian151390800002
    TROUP, Alistair Charles Westray
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    Administrateur
    Gadbrook Park
    Rudheath
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    United Kingdom
    United KingdomBritish111421130001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PRIZE VENTURES LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    23 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    PRIZE VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 nov. 2013
    Livré le 19 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 nov. 2013
    Livré le 19 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    An irish law share charge
    Créé le 30 sept. 2011
    Livré le 07 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title benefit and interest in respect of the investments being the shares and all related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 07 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 09 avr. 2010
    Acquis le 30 sept. 2011
    Livré le 07 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The transferred assets, being- the shares and all present and future related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 07 oct. 2011Enregistrement d'une acquisition (MG06)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 09 avr. 2010
    Livré le 13 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 oct. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 14 nov. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A charge of shares
    Créé le 09 avr. 2010
    Livré le 13 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its respective rights title benefit and interest to or in respect of the investments see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    PRIZE VENTURES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mai 2019Commencement of winding up
    30 avr. 2019Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    practitioner
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    practitioner
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0