SRC TRANSATLANTIC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSRC TRANSATLANTIC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 07225997
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SRC TRANSATLANTIC LIMITED ?

    • Autre octroi de crédit n.c.a. (64929) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SRC TRANSATLANTIC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor 30 - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SRC TRANSATLANTIC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SRC TRANSATLANTIC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    32 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    32 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    38 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    52 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Duncan Peter Marrison en tant que directeur le 31 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    40 pagesAM03

    Résultat de la réunion des créanciers

    5 pagesAM07

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    9 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    9 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    9 pagesAM02

    Cessation de la nomination de Julian Miles Graham-Rack en tant que directeur le 26 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Cessation de la nomination de Donald Francis Gayhardt en tant que directeur le 22 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2017

    43 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 20 déc. 2017

    • Capital: GBP 106,400,100
    3 pagesSH01

    Nomination de Mr Duncan Peter Marrison en tant qu'administrateur le 01 mars 2018

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2016

    46 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Philip John Anderson en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de Philip John Anderson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2017

    1 pagesPSC07

    Qui sont les dirigeants de SRC TRANSATLANTIC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAKER, William
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    United StatesAmerican205659060001
    THOMAS IV, Eugene Marvin
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    United StatesAmerican206957980001
    STEELE, Thomas
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    England
    Secrétaire
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    England
    169564970001
    ANDERSON, Philip John
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Wellington Plaza, 31
    Leeds
    England
    Administrateur
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Wellington Plaza, 31
    Leeds
    England
    ScotlandBritish202160260002
    CHARLES, Michael
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    England
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    England
    EnglandAmerican175652260001
    FAULKNER, Chadwick
    North Ridge Road
    67205 Wichita
    3527
    Kansas
    Usa
    Administrateur
    North Ridge Road
    67205 Wichita
    3527
    Kansas
    Usa
    United StatesAmerican150583180001
    GAYHARDT, Donald Francis
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    England
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    England
    United StatesAmerican67600210001
    GRAHAM-RACK, Julian Miles
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    EnglandBritish172598790001
    MARRISON, Duncan Peter Edmund
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    EnglandBritish238962000001
    MAZZINI, Philip Lawrence
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    UsaUsa190839620001
    RIPPEL, Douglas
    North Ridge Road
    67205 Wichita
    3527
    Kansas
    Usa
    Administrateur
    North Ridge Road
    67205 Wichita
    3527
    Kansas
    Usa
    UsaAmerican150583190001
    TRAILOR, Timothy Morgan
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Administrateur
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    United KingdomBritish205417220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SRC TRANSATLANTIC LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr. Philip John Anderson
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    07 avr. 2016
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr. Donald Gayhardt
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    07 avr. 2016
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Non
    Nationalité: American
    Pays de résidence: United States
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr Julian Miles Graham-Rack
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    07 avr. 2016
    - 34
    Hounds Gate
    NG1 7AB Nottingham
    First Floor 30
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SRC TRANSATLANTIC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 28 sept. 2012
    Livré le 17 oct. 2012
    En cours
    Montant garanti
    £40,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit and other amounts payable to the landlord under the lease.
    Personnes ayant droit
    • Network Rail Infrastructure Limited
    Transactions
    • 17 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 sept. 2012
    Livré le 28 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The account and the deposit balance see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited
    Transactions
    • 28 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 juin 2012
    Livré le 20 juin 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Cash deposit of £26,250.00.
    Personnes ayant droit
    • Bastion Investments Limited
    Transactions
    • 20 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit
    Créé le 09 mars 2012
    Livré le 20 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    £21,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Saracens Securities Limited
    Transactions
    • 20 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 08 mars 2012
    Livré le 09 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    £20,833.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Rent deposit.
    Personnes ayant droit
    • London & Henley (Bromley) Limited
    Transactions
    • 09 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 févr. 2012
    Livré le 24 févr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed equitable charge over the deposit balance paid into the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Second Quartet LP Acting by It's General Partner Second Quartet (General Partner) Sub Limited and Second Quartet Investment (Nominee) Limited
    Transactions
    • 24 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 déc. 2011
    Livré le 10 déc. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its interest in the account and all its interest in the deposit balance.
    Personnes ayant droit
    • Ropemaker Properties Limited
    Transactions
    • 10 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 14 nov. 2011
    Livré le 17 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The balance from time to time standing to the credit of an account, the opening balance of the account £16,950.00 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Thistle Investments Limited and Palace Investments Limited
    Transactions
    • 17 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 31 oct. 2011
    Livré le 12 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (trading as speedy cash) to salford estates (no.2) limited in its capacity as general partner of the salford estates limited partnership and salford estates nominees limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit of £14,000.00 plus an amount equal to vat in the sum of £2,800.00 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Salford Estates (No.2) Limited and Salford Estates Nominees Limited
    Transactions
    • 12 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 23 nov. 2010
    Livré le 26 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re src transatlantic limited business premium account account number 03608980.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 mai 2010
    Livré le 02 juin 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's interest in the bank account in which the rent deposit monies are placed and the rent deposit monies initially £76,375.00.
    Personnes ayant droit
    • LCP Securities Limited
    Transactions
    • 02 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)

    SRC TRANSATLANTIC LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 févr. 2019Administration started
    29 déc. 2020Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Edward George Boyle
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Howard Smith
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0