BYRON HAMBURGERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBYRON HAMBURGERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 07228130
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BYRON HAMBURGERS LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration

    Où se situe BYRON HAMBURGERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BYRON HAMBURGERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au24 juin 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour BYRON HAMBURGERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de nomination d'un administrateur remplaçant ou supplémentaire

    3 pagesAM11

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    30 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    105 pagesAM16

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    26 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL à 10 Fleet Place London EC4M 7QS le 18 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    10 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    57 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Changement d'adresse du siège social de 82 Dean Street London W1D 3SP England à Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL le 24 août 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr David John Pepper en tant qu'administrateur le 17 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 14-15 Berners Street London W1T 3LJ United Kingdom à 82 Dean Street London W1D 3SP le 13 août 2019

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 24 juin 2018

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Steven Michael De Polo en tant que directeur le 19 juin 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Simon Wilkinson en tant qu'administrateur le 09 mai 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Russell Hoare en tant que directeur le 09 mai 2019

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    26 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de BYRON HAMBURGERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEPPER, David John
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish81175350001
    WILKINSON, Simon
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish258484590001
    BOSTON, Simon Atwell
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    183096430001
    CARTER, Nicholas Michael
    Floor
    Balcombe Street
    NW1 6NW London
    5th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    Balcombe Street
    NW1 6NW London
    5th
    United Kingdom
    150640160001
    BOSTON, Simon Atwell
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish177057250001
    BYNG, Thomas Francis Edmund
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish165149270001
    CARTER, Nicholas Michael
    Floor
    Balcombe Street
    NW1 6NW London
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Balcombe Street
    NW1 6NW London
    5th
    United Kingdom
    EnglandBritish150640180001
    COPE, Simon
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish233138640001
    DE POLO, Steven Michael
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish253069680001
    HOARE, Russell
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish205076470001
    MANDERS, Andrew Craig
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish227485800001
    PHILLIPS, Dalton Timothy
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    IrelandIrish238021740001
    SMYTH, Harvey John
    Floor
    Balcombe Street
    NW1 6NW London
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Balcombe Street
    NW1 6NW London
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritish74178000002
    WICKERS, Neil David
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    United Kingdom
    EnglandBritish165149080001
    YOUNG, Nicholas John
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    14-15 Berners Street
    W1T 3LJ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish239367860001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BYRON HAMBURGERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Berners Street
    W1T 3LJ London
    14-15
    England
    06 avr. 2016
    Berners Street
    W1T 3LJ London
    14-15
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement08674679
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BYRON HAMBURGERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 31 janv. 2019
    Livré le 06 févr. 2019
    En cours
    Brève description
    The intellectual property rights as defined in the charge and including (but not limited to): the registered trademarks being the stylised word "byron" with the registration numbers: 1229102 registered in the eu on 3/11/2015; 303088288 registered in hong kong on 18/02/2015, and 1229102 registered on the international register on 25/12/2014.. see schedule 1 part b of the charge for more details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pall Mall Secondary Am S.À R.L.
    Transactions
    • 06 févr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 avr. 2018
    Livré le 05 avr. 2018
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 juin 2016
    Livré le 04 juil. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The property registered under title numbers NGL923059, NGL931409 as further described in schedule 2 to the group debenture; the intellectual property registered under trade mark numbers 2468067, 2498589 and 2617196 and any other property described in schedule 2 to the group debenture against the name of the company as being charged by the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC (As Security Trustee for the Secured Parties (as Defined in the Instrument))
    Transactions
    • 04 juil. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 05 août 2014
    Livré le 09 août 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    45-47 hoxton square london t/no AGL232995.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 09 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 avr. 2014
    Livré le 19 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Sabian house 26/27 cowcross street london title no NGL785019.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 avr. 2014
    Livré le 10 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 mars 2014
    Livré le 20 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    93/95 old brompton road, london t/no:BGL75601.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 20 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 févr. 2014
    Livré le 22 févr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Basement ground floor and first floor flat 6 rathbone place london t/n NGL923059. Unit 2 ground floor 4,6 and 10-26A jamestown road camden london t/n NGL931409. 97-99 wardout street london t/n NGL907799. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 22 févr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 sept. 2011
    Livré le 20 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 20 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accessin deed
    Créé le 25 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    BYRON HAMBURGERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 févr. 2018Date of meeting to approve CVA
    06 juil. 2018Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Andrew Croxen
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    2
    DateType
    31 juil. 2020Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Claire Sophie Winder
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0