S.O REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéS.O REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 07434105
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de S.O REALISATIONS LIMITED ?

    • Activités de services de systèmes de sécurité (80200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe S.O REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Broadgate House Broadgate, Oldham Broadway Business Park
    Chadderton
    OL9 9XA Oldham
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de S.O REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SECURE OPTIONS (UK) LIMITED06 mai 201106 mai 2011
    HLW 416 LIMITED09 nov. 201009 nov. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour S.O REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 août 2013

    21 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 22 août 2013

    21 pages2.35B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 22 août 2013

    22 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 mars 2013

    18 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    46 pages2.17B

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de Commercial House Commercial Street Sheffield South Yorkshire S1 2AT le 09 août 2012

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2012 au 31 mars 2011

    1 pagesAA01

    legacy

    8 pagesMG01

    legacy

    9 pagesMG01

    legacy

    9 pagesMG01

    legacy

    14 pagesMG01
    Annotations
    DateAnnotation
    16 avr. 2012Clarification This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    legacy

    7 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 déc. 2011

    État du capital au 21 déc. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    9 pagesMG01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 nov. 2011 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    legacy

    5 pagesMG02

    Subdivision des actions au 18 août 2011

    5 pagesSH02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Existing share capital of the company 1 ordinary share of £1 be sub-divided into 100 ordinary shares of £0.01 each having the rights and subject to restrictions contained in the company's articles of association 18/08/2011
    RES13

    Cessation de la nomination de John Sykes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de S.O REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOVARD, Martin John
    162 Middleton Road
    Royton
    OL2 5LS Oldham
    Lane End Works
    England
    Administrateur
    162 Middleton Road
    Royton
    OL2 5LS Oldham
    Lane End Works
    England
    United KingdomBritishConsultant110275710001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    Smiths End Lane
    SG8 8LH Barley
    The Thatched Cottage
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Smiths End Lane
    SG8 8LH Barley
    The Thatched Cottage
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishNone95086050001
    DYSON, Roger Kenneth
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    England
    Administrateur
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor84430830001
    SYKES, John George
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    Administrateur
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant67867030002

    S.O REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of variation
    Créé le 03 juil. 2012
    Livré le 18 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and camwatch limited to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Maven Capital Partners UK LLP
    Transactions
    • 18 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 09 avr. 2012
    Livré le 26 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and camwatch limited to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Julian Frederick Nicholls, Philip John Bunting, Glyn Michael Abba, Michael Collis, James Dainty and John Robertson
    Transactions
    • 26 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2012
    Livré le 17 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or camwatch limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Core Capital LLP as Security Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2012
    Livré le 12 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and camwatch limited to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Maven Capital Partners UK LLP
    Transactions
    • 12 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2012
    Livré le 16 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 16 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 18 nov. 2011
    Livré le 19 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transactions
    • 19 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 24 mai 2011
    Livré le 26 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Secure Options Group Limited Brightstar Consultants Limited Charlton Doors Limited Leerose Integrated Systems Limited Monitored Solutions Limited Nu-Cam Integrated Systems Limited P.a>T Security Systems Limited Secure by Integrity Limited Secure Options High Security Division Limited Secure Options Holdings Limited Secure Options Limited Watchman Traffic Limited
    Transactions
    • 26 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    S.O REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 sept. 2012Administration started
    22 août 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    practitioner
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Stephen Gerard Clancy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    practitioner
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0