INTERIORS MANUFACTURING LIMITED

INTERIORS MANUFACTURING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERIORS MANUFACTURING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 07693359
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERIORS MANUFACTURING LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe INTERIORS MANUFACTURING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERIORS MANUFACTURING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GATEWAY BIDCO LIMITED05 juil. 201105 juil. 2011

    Quels sont les derniers comptes de INTERIORS MANUFACTURING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERIORS MANUFACTURING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    27 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    26 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 17 juin 2016

    35 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    16 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    116 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Cunard House 15 Regent Street London SW1Y 4LR à 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ le 08 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Nomination de Mr Edward John Riley en tant qu'administrateur le 21 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Edward Riley en tant que secrétaire le 30 sept. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Peter Thomond O'brien en tant que directeur le 21 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Sime en tant que directeur le 30 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Sime en tant que secrétaire le 30 sept. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2015

    État du capital au 30 juil. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Nick David Kipling Prosser en tant que directeur le 10 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Colin Hopkinson en tant que directeur le 25 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nick David Kipling Prosser en tant que directeur le 10 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Milnhay Road Langley Mill Nottingham NG16 4AZ England à Cunard House 15 Regent Street London SW1Y 4LR le 14 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2014 au 31 déc. 2014

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Cunard House 15 Regent Street London SW1Y 4LR à Milnhay Road Langley Mill Nottingham NG16 4AZ le 12 mars 2015

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de INTERIORS MANUFACTURING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RILEY, Edward
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Secrétaire
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    202659450001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Rutland Partners Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Rutland Partners Llp
    United Kingdom
    EnglandBritish40873830003
    JEFFERIES, John
    Strawberry Lane
    WV13 3RS Willenhall
    Unit 23
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Strawberry Lane
    WV13 3RS Willenhall
    Unit 23
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish132190060001
    RILEY, Edward John
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    EnglandBritish60757430002
    SATSANGI, Rahul
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Rutland Partners Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Rutland Partners Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish161298780001
    CLARK, Trevor John
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    Secrétaire
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    174194450001
    HOSKIN, Alison Ruth
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    Secrétaire
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    180133390001
    SIME, Alan
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Secrétaire
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    193062620001
    CLEMENT, Craig Darren
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    EnglandBritish102403040003
    HOPKINSON, Ian Colin
    Strawberry Lane
    WV13 3RS Willenhall
    Unit 23
    West Midlands
    Administrateur
    Strawberry Lane
    WV13 3RS Willenhall
    Unit 23
    West Midlands
    WalesBritish76627690001
    MALHAN, Ashwani
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    United Kingdom
    United KingdomBritish12433290007
    O'BRIEN, Peter Thomond
    Strawberry Lane
    WV13 3RS Willenhall
    Unit 23
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Strawberry Lane
    WV13 3RS Willenhall
    Unit 23
    West Midlands
    England
    EnglandEnglish,Irish54240700002
    PROSSER, Nick David Kipling
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    EnglandBritish178682250001
    SIME, Alan
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    EnglandBritish51759580002

    INTERIORS MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    All asset debenture
    Créé le 20 déc. 2012
    Livré le 22 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    12-61 (odd) parkwood road and land and buildings adjoining on the west side sheffield t/no SYK417494 and land on the east side of milnhay road langley mill t/no DY195902 and land lying to the north and east of milnhay road langley mill t/no DY215287 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2012
    Livré le 25 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, cubicle systems limited, laidlaw interiors limited or any company which becomes a party by executing and delivering a deed of accession and each grantor of security to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ashwani Malhan
    Transactions
    • 25 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 12 janv. 2012
    Livré le 26 janv. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit of £155,000 credited to account number 22695923 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 01 août 2011
    Livré le 09 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as gateway bidco limited, gateway 2 limited (now known as laidlaw interiors limited), cubicle systems limited or any company which becomes a party and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP
    Transactions
    • 09 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)

    INTERIORS MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2015Administration started
    28 déc. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Michael Hawes
    Deloitte Llp 3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    practitioner
    Deloitte Llp 3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0