MCKECHNIE BRASS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMCKECHNIE BRASS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 07773851
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MCKECHNIE BRASS LIMITED ?

    • production d'autres métaux non ferreux (24450) / Industries manufacturières
    • fonte d'autres métaux non ferreux (24540) / Industries manufacturières

    Où se situe MCKECHNIE BRASS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O DUFF + PHELPS LTD
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MCKECHNIE BRASS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HC 1169 LIMITED14 sept. 201114 sept. 2011

    Quels sont les derniers comptes de MCKECHNIE BRASS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour MCKECHNIE BRASS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    22 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2016

    19 pages4.68

    Cessation de la nomination de Leszek Litwinowicz en tant que secrétaire le 18 oct. 2016

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter Francis Lombardi en tant que directeur le 18 oct. 2016

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Hankinson en tant que directeur le 18 oct. 2016

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Leszek Richard Litwinowicz en tant que directeur le 18 oct. 2016

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathon David Grove en tant que directeur le 18 oct. 2016

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2015

    18 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator
    13 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 oct. 2015

    17 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 oct. 2014

    23 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 29 juin 2014

    22 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    18 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    47 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * 5 the Courtyard Timothys Bridge Road Stratford upon Avon Warwickshire CV37 9NP* le 13 janv. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Nomination de Mr Colin Michael Tiernan en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Robert Hankinson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 sept. 2013

    État du capital au 23 sept. 2013

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MCKECHNIE BRASS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CRILLY, Robert Christopher
    Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    35
    Administrateur
    Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    35
    United KingdomBritishNone163916940001
    TIERNAN, Colin Michael
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNone30045420002
    LITWINOWICZ, Leszek
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 0DB Stratford Upon Avon
    5
    England
    Secrétaire
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 0DB Stratford Upon Avon
    5
    England
    163022790001
    EAGER, Mary Elizabeth
    Timothys Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Timothys Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone115444600001
    GROVE, David Leslie
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 0DB Stratford Upon Avon
    5
    England
    Administrateur
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 0DB Stratford Upon Avon
    5
    England
    EnglandBritishCompany Director4174280001
    GROVE, Jonathon David
    Timothy's Bridge Road
    Stratford Enterprise Park
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Timothy's Bridge Road
    Stratford Enterprise Park
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director165212210001
    HANKINSON, Robert
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    Uk
    Administrateur
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    Uk
    UkBritishAccountant183765140001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 0DB Stratford Upon Avon
    5
    England
    Administrateur
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 0DB Stratford Upon Avon
    5
    England
    United KingdomBritishCompany Director70815770006
    LOMBARDI, Peter Francis
    Kemps Green Road
    Balsall Common
    CV7 7QF Coventry
    73
    England
    Administrateur
    Kemps Green Road
    Balsall Common
    CV7 7QF Coventry
    73
    England
    EnglandBritishCompany Director90213680001
    TRUESDALE, Thomas Alan
    Timothys Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    Administrateur
    Timothys Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    5 The Courtyard
    Warwickshire
    United KingdomBritishGeneral Manager166569040001

    MCKECHNIE BRASS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 juil. 2013
    Livré le 29 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 29 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Chattel mortgage
    Créé le 20 juil. 2012
    Livré le 31 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The equipment being avery berkel L126 electronic floor mounted scale, unnamed 6 finger hydraulic crane grab, eldair mobile crocodile shear plant no: 1030 and cropping machine plant no: 3440 (for further chattels charged please refer to form MG01) together with any part or parts thereof and all additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Asset Finance Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 juil. 2012
    Livré le 25 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in the account and interest in the deposit balance see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cbre Spul 11 (No 20) Limited
    Transactions
    • 25 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 sept. 2011
    Livré le 08 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a hc 1169 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all its interest in the account and in its interest in the deposit balance and all its rights. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cbre Spuk Ii (No 20) Limited
    Transactions
    • 08 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 28 sept. 2011
    Livré le 04 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 04 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 28 sept. 2011
    Livré le 01 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Grove Industries Limited
    Transactions
    • 01 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)

    MCKECHNIE BRASS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 déc. 2013Administration started
    02 oct. 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Neville Whitfield
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    practitioner
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Jason James Godefroy
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    practitioner
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    2
    DateType
    02 oct. 2014Commencement of winding up
    29 avr. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    John Neville Whitfield
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    proposed liquidator
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Jason James Godefroy
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    proposed liquidator
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0