THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 07902965 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Brennan House Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 févr. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 08 mars 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 févr. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2025 | 19 pages | AA | ||
legacy | 58 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 févr. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andy Thompson le 03 août 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Inscription de la charge 079029650003, créée le 13 oct. 2025 | 36 pages | MR01 | ||
legacy | 57 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2024 | 20 pages | AA | ||
legacy | 57 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Darren William John Sharkey le 22 févr. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andy Thompson le 22 févr. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Inscription de la charge 079029650002, créée le 29 nov. 2024 | 36 pages | MR01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2023 | 21 pages | AA | ||
legacy | 53 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 53 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Qui sont les dirigeants de THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDTHORPE, Simon Timothy | Administrateur | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 14508630008 | |||||
| SHARKEY, Darren William John | Administrateur | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | Irish | 50612110035 | |||||
| THOMPSON, Andrew Bernard | Administrateur | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | United Kingdom | British | 299614380002 | |||||
| CHARD, Nicola Ruth | Secrétaire | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire Uk | 165753370001 | |||||||
| JARDINE, Jacqueline | Secrétaire | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | 171818040002 | |||||||
| SNASHFOLD, Sandra Lee | Secrétaire | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | 181493710001 | |||||||
| BALKHAM, Shane Michael | Administrateur | Nutfield Road RH1 3HA Merstham 78 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 128186970001 | |||||
| BENNETT, Andrew John | Administrateur | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 167934380001 | |||||
| BILLINGHAM, Philip Leonard | Administrateur | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | England | British | 58337260008 | |||||
| CHARD, Nicola Ruth | Administrateur | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire Uk | United Kingdom | British | 96229310002 | |||||
| DUNNE, Derrick William | Administrateur | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 92454160002 | |||||
| EASTER, Alan James | Administrateur | Marline Court Little High Street BH43 5EQ Shoreham By Sea 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 167936610001 | |||||
| GOLDTHORPE, Clive Simon | Administrateur | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | England | British | 152101520005 | |||||
| GRAINGER, Paul Timothy | Administrateur | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | England | Irish | 217625630001 | |||||
| INGRAM, David John | Administrateur | Green Lane Heatons Moor SK4 3LH Stockport 79 Cheshire United Kingdom | England | British | 154583950001 | |||||
| JARDINE, Jacqueline | Administrateur | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Portugal | British | 195697240010 | |||||
| JARDINE, Jacqueline | Administrateur | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | England | British | 152279920002 | |||||
| SNASHFOLD, Sandra Lee | Administrateur | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | England | British | 141604910001 | |||||
| SWANSTON, Jade Marie | Administrateur | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 279571720001 | |||||
| WATSON, Stephen Grant | Administrateur | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | England | British | 96296070001 | |||||
| WILLIAMS, Peter John, Dr | Administrateur | Chestnut Close Horbury WF4 5QF Wakefield 1 Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 166319680001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finli Advice Holdings Limited | 30 juin 2023 | Davy Avenue Knowlhill MK5 8HJ Milton Keynes C/O Freeths Llp Routeco Office Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| James Christopher Flowers | 03 août 2022 | 767 Fifth Avenue 10153 New York 23rd Floor Ny United States | Oui | ||||||||||
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mrs Jade Marie Swanston | 27 janv. 2021 | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Derrick William Dunne | 27 août 2020 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Paul Timothy Grainger | 01 nov. 2018 | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: Irish Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Marlborough Group Holdings Limited | 24 janv. 2018 | Chorley New Road BL1 4QP Bolton Marlborough House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Stephen Grant Watson | 06 avr. 2016 | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mrs Jacqueline Jardine | 06 avr. 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Clive Simon Goldthorpe | 06 avr. 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Simon Timothy Goldthorpe | 06 avr. 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Andrew John Bennett | 06 avr. 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0