MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD

MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 08033025
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution
    • Traitement et élimination des déchets non dangereux (38210) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution
    • Récupération de matériaux triés (38320) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    Adresse du siège social
    Suez House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SITA SEMBCORP UK LIMITED30 avr. 201230 avr. 2012
    SHUKCO 312A LIMITED17 avr. 201217 avr. 2012

    Quels sont les derniers comptes de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr. Richard Geoffrey Little en tant qu'administrateur le 30 nov. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Daniel Geoffrey North en tant que directeur le 30 nov. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    36 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Bruce Sheffer en tant que directeur le 25 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. David Anthony Morris en tant qu'administrateur le 07 mai 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Iqbal Singh Sidhu en tant qu'administrateur le 20 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Thomas Patrick en tant que directeur le 20 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Philip Bruce Sheffer en tant qu'administrateur le 20 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew John Cottrell en tant que directeur le 31 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Daniel North en tant qu'administrateur le 15 août 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Neil Rae en tant qu'administrateur le 15 août 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kazuma Fukao en tant que directeur le 15 août 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rahul Dipinkumar Kadiwar en tant que directeur le 15 août 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    36 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Andrew John Cottrell en tant qu'administrateur le 01 déc. 2023

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    36 pagesAA

    Cessation de la nomination de Belinda Faith Knox en tant que directeur le 01 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Rahul Dipinkumar Kadiwar en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Keith Thompson en tant que directeur le 31 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Masashi Kanai en tant que directeur le 01 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Kazuma Fukao en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    36 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK LTD
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02291198
    114869260003
    LITTLE, Richard Geoffrey, Mr.
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Administrateur
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    EnglandBritish151062990002
    MORRIS, David Anthony, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish335522840001
    PADFIELD, Amanda
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159090300001
    RAE, Neil, Mr.
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Administrateur
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    United KingdomBritish119437600003
    SIDHU, Iqbal Singh, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish332910240001
    THOMPSON, Mark Hedley
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish162837220002
    THORN, Christopher Derrick, Mr.
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish266799220001
    KNIGHT, Joan
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    168388440001
    AHMAD, Nauman
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandPakistani246516040001
    ANNAN, Douglas Stuart, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish165609970001
    BONE, Dugald John, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish84834380001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandFrench122645500003
    CHONG, Kwong Fatt
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Administrateur
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    SingaporeSingaporean183833580001
    COTTRELL, Andrew John
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish334057500001
    FUKAO, Kazuma
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Administrateur
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese308897090001
    GAVIN, Paul
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159027960001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Administrateur
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    EnglandBritish205116300001
    HIBINO, Tsuneharu
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandJapanese168730210001
    HIGASHIYAMA, Eiichiro
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    Administrateur
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    EnglandJapanese195916850001
    KADIWAR, Rahul Dipinkumar
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    Administrateur
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish313395690001
    KANAI, Masashi
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Administrateur
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese282813470002
    KNOX, Belinda Faith
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Administrateur
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish190578640001
    MCCLAY, Catherine Isabel, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish245734420001
    MCKENNA-MAYES, Graham Arthur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91435430011
    NG, Meng Poh
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    SingaporeSingaporean150975730001
    NORTH, Daniel Geoffrey
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Administrateur
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    EnglandBritish259587080001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish125070620001
    PATRICK, Michael Thomas
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish293354340001
    SCRIMSHAW, Matthew Giles
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish265146200001
    SEXTON, Ian Anthony
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    FranceBritish182259120001
    SHEFFER, Philip Bruce, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish332909490001
    SUZUKI, Yuji
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Administrateur
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese236854110002
    THOMPSON, David Keith
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish265146580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    06 avr. 2016
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07983197
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0