MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 08033025 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?
| Adresse du siège social | Suez House Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 01 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr. Richard Geoffrey Little en tant qu'administrateur le 30 nov. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Daniel Geoffrey North en tant que directeur le 30 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2025 | 36 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Philip Bruce Sheffer en tant que directeur le 25 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr. David Anthony Morris en tant qu'administrateur le 07 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr. Iqbal Singh Sidhu en tant qu'administrateur le 20 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Thomas Patrick en tant que directeur le 20 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr. Philip Bruce Sheffer en tant qu'administrateur le 20 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew John Cottrell en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr. Daniel North en tant qu'administrateur le 15 août 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr. Neil Rae en tant qu'administrateur le 15 août 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Kazuma Fukao en tant que directeur le 15 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Rahul Dipinkumar Kadiwar en tant que directeur le 15 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 36 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr. Andrew John Cottrell en tant qu'administrateur le 01 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 36 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Belinda Faith Knox en tant que directeur le 01 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Rahul Dipinkumar Kadiwar en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de David Keith Thompson en tant que directeur le 31 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Masashi Kanai en tant que directeur le 01 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Kazuma Fukao en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2022 | 36 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK LTD | Secrétaire | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England |
| 114869260003 | ||||||||||
| LITTLE, Richard Geoffrey, Mr. | Administrateur | 1 Gresham Street EC2V 7BX London Semperian, 4th Floor England | England | British | 151062990002 | |||||||||
| MORRIS, David Anthony, Mr. | Administrateur | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar Cleveland Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 335522840001 | |||||||||
| PADFIELD, Amanda | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 159090300001 | |||||||||
| RAE, Neil, Mr. | Administrateur | 1 Gresham Street EC2V 7BX London Semperian, 4th Floor England | United Kingdom | British | 119437600003 | |||||||||
| SIDHU, Iqbal Singh, Mr. | Administrateur | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar, Cleveland Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | United Kingdom | British | 332910240001 | |||||||||
| THOMPSON, Mark Hedley | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 162837220002 | |||||||||
| THORN, Christopher Derrick, Mr. | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 266799220001 | |||||||||
| KNIGHT, Joan | Secrétaire | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | 168388440001 | |||||||||||
| AHMAD, Nauman | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | Pakistani | 246516040001 | |||||||||
| ANNAN, Douglas Stuart, Dr | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 165609970001 | |||||||||
| BONE, Dugald John, Dr | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | England | British | 84834380001 | |||||||||
| CHAPRON, Christophe Andre Bernard | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | England | French | 122645500003 | |||||||||
| CHONG, Kwong Fatt | Administrateur | Wilton Internation TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters Cleveland England | Singapore | Singaporean | 183833580001 | |||||||||
| COTTRELL, Andrew John | Administrateur | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | United Kingdom | British | 334057500001 | |||||||||
| FUKAO, Kazuma | Administrateur | 20 Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | Japanese | 308897090001 | |||||||||
| GAVIN, Paul | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | England | British | 159027960001 | |||||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Administrateur | Wilton Internation TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters Cleveland England | England | British | 205116300001 | |||||||||
| HIBINO, Tsuneharu | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | Japanese | 168730210001 | |||||||||
| HIGASHIYAMA, Eiichiro | Administrateur | The Broadgate Tower, 20 Primrose Street EC2A 2EW London I-Environment Investments Ltd England | England | Japanese | 195916850001 | |||||||||
| KADIWAR, Rahul Dipinkumar | Administrateur | 20 Primrose Street EC2A 2EW London I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower England | England | British | 313395690001 | |||||||||
| KANAI, Masashi | Administrateur | 20 Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | Japanese | 282813470002 | |||||||||
| KNOX, Belinda Faith | Administrateur | 20 Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | British | 190578640001 | |||||||||
| MCCLAY, Catherine Isabel, Dr | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 245734420001 | |||||||||
| MCKENNA-MAYES, Graham Arthur | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 91435430011 | |||||||||
| NG, Meng Poh | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | Singapore | Singaporean | 150975730001 | |||||||||
| NORTH, Daniel Geoffrey | Administrateur | 1 Gresham Street EC2V 7BX London Semperian, 4th Floor England | England | British | 259587080001 | |||||||||
| PALMER-JONES, David Courtenay | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | United Kingdom | British | 125070620001 | |||||||||
| PATRICK, Michael Thomas | Administrateur | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar Sembcorp Uk Headquarters Cleveland United Kingdom | England | British | 293354340001 | |||||||||
| SCRIMSHAW, Matthew Giles | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 265146200001 | |||||||||
| SEXTON, Ian Anthony | Administrateur | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | France | British | 182259120001 | |||||||||
| SHEFFER, Philip Bruce, Mr. | Administrateur | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar, Cleveland Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 332909490001 | |||||||||
| SUZUKI, Yuji | Administrateur | Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | Japanese | 236854110002 | |||||||||
| THOMPSON, David Keith | Administrateur | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar Sembcorp Uk Headquarters Cleveland United Kingdom | England | British | 265146580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merseyside Energy Recovery Holdings Ltd | 06 avr. 2016 | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0