LARK (2012) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LARK (2012) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 08043688 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LARK (2012) LIMITED ?
| Adresse du siège social | One Creechurch Place EC3A 5AF London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LARK (2012) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour LARK (2012) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Annulation d'actions. État du capital au 16 mai 2023
| 4 pages | SH06 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021 | 6 pages | AA | ||
legacy | 59 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2022 au 30 sept. 2022 | 1 pages | AA01 | ||
Cessation de la nomination de Timothy Mark Holland en tant que directeur le 31 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des détails de Aston Lark Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mai 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de 8th Floor Ibex House 42-47 Minories London EC3N 1DY United Kingdom à One Creechurch Place London EC3A 5AF le 12 mai 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Eversheds Sutherland (International) Llp 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom à 2 New Bailey 6 Stanley Street Salford Manchester M3 5GS | 1 pages | AD02 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||
legacy | 46 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Cessation de la nomination de Stephen John Starling Lark en tant que directeur le 23 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Carl Whitmore Brown en tant que directeur le 01 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019 | 14 pages | AA | ||
legacy | 45 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Qui sont les dirigeants de LARK (2012) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC, Peter William | Administrateur | Creechurch Place EC3A 5AF London One United Kingdom | England | English | 56337490004 | |||||||||
| BROWN, Carl Whitmore | Secrétaire | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex United Kingdom | 171299870001 | |||||||||||
| SNR DENTON SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Fleet Place EC4M 7WS London One England |
| 98515470002 | ||||||||||
| BROWN, Carl Whitmore | Administrateur | Ibex House 42-47 Minories EC3N 1DY London 8th Floor United Kingdom | England | British | 109663580001 | |||||||||
| CAMPBELL, Sally Victoria | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex | United Kingdom | British | 188508810001 | |||||||||
| DAINES, Mark John | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex | England | British | 204465900001 | |||||||||
| DUPPLIN, Charles William Harley Hay, Viscount | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 45387980002 | |||||||||
| FOSTER, David Frederick | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex United Kingdom | England | British | 130085480001 | |||||||||
| HARRIS, Andrew David | Administrateur | Fleet Place EC4M 7WS London One England | United Kingdom | British | 135336690001 | |||||||||
| HOLLAND, Timothy Mark | Administrateur | Creechurch Place EC3A 5AF London One United Kingdom | United Kingdom | British | 221315490001 | |||||||||
| KEENE, Robert John | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex | England | British | 193431500001 | |||||||||
| LARK, Graham Robert Starling | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex United Kingdom | England | British | 33449530002 | |||||||||
| LARK, Stephen John Starling | Administrateur | Ibex House 42-47 Minories EC3N 1DY London 8th Floor United Kingdom | England | British | 141442120001 | |||||||||
| MASTERS, Julian James Lawrence | Administrateur | Eagle Place SW1Y 6AF London One England | United Kingdom | British | 142675990003 | |||||||||
| TORBET, David | Administrateur | Eagle Place SW1Y 6AF London One England | United Kingdom | British | 123340890005 | |||||||||
| WHITEHEAD, Julie Dawn | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex United Kingdom | England | British | 161470940001 | |||||||||
| WOODWARD, Mark Robert | Administrateur | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex United Kingdom | England | British | 96931320002 | |||||||||
| SNR DENTON DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Fleet Place EC4M 7WS London One England |
| 111005580002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LARK (2012) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope (Bidco) Limited | 23 avr. 2018 | Town Hill ME19 6QL West Malling Malling House Kent United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Antelope (Topco) Limited | 23 avr. 2018 | Town Hill ME19 6QL West Malling Malling House Kent United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aston Scott Group Limited | 23 avr. 2018 | ME19 6QL West Malling Malling House, Town Hill Kent United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Antelope (Midco) Limited | 23 avr. 2018 | Town Hill ME19 6QL West Malling Malling House Kent United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aston Lark Group Limited | 23 avr. 2018 | Creechurch Place EC3A 5AF London One United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Bowmark Capital Llp | 24 oct. 2017 | Eagle Place SW1Y 6AF London One England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aston Lark (Bidco) Limited | 24 oct. 2017 | Eagle Place SW1Y 6AF London One England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Graham Robert Starling Lark | 06 avr. 2016 | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Stephen John Starling Lark | 06 avr. 2016 | Wakering Road IG11 8PJ Barking Wigham House Essex | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Hiscox Plc | 06 avr. 2016 | Great St. Helens EC3A 6HX London 1 Great St Helens England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LARK (2012) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 15 nov. 2017 Livré le 21 nov. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All current and future land (except for any restricted land) and intellectual property (except for any restricted ip) owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Share charge | Créé le 06 août 2012 Livré le 21 août 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The shares and the derivative assets and includes all rights benefits and sums on or after the charge date accruing to the chargeing company in connection with the shares and the derivative assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0