CARD FACTORY PLC
Vue d'ensemble
Nom de la société | CARD FACTORY PLC |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
Numéro de société | 09002747 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARD FACTORY PLC ?
Adresse du siège social | Century House Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield West Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARD FACTORY PLC ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 janv. 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 juil. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARD FACTORY PLC ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 avr. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 01 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 avr. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CARD FACTORY PLC ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État du capital après une attribution d'actions au 03 févr. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 janv. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 11 déc. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 25 nov. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 28 oct. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 30 sept. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 août 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nathan Lane en tant que directeur le 26 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 janv. 2024 | 169 pages | AA | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 14 juin 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Mark Whiteside en tant que directeur le 20 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Pamela Powell en tant qu'administrateur le 21 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 28 mai 2024
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 09 avr. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Inscription de la charge 090027470003, créée le 26 avr. 2024 | 56 pages | MR01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 25 mars 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 févr. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 22 janv. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 déc. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 13 nov. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 12 oct. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 11 juil. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CARD FACTORY PLC ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STONE, Ciaran Joseph | Secrétaire | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | 269368390001 | |||||||||||
MCWILLIAM, Robert Gerard | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Accountant | 177972140001 | ||||||||
MOODY, Paul Stephen | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Chairman | 271684570001 | ||||||||
POWELL, Pamela | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | American,British | Company Director | 178130510002 | ||||||||
SEEGER, Matthias Alexander | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | German | Finance Director | 309574790001 | ||||||||
THAMBIAH, Indira | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Director | 125997450001 | ||||||||
WILLSON-RYMER, Darcy | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Company Director | 280585620001 | ||||||||
SIBAL, Shiv | Secrétaire | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | 187616250001 | |||||||||||
HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | One Silk Street EC2Y 8HQ London C/O Hackwood Secretaries Limited |
| 147306890001 | ||||||||||
BRYANT, Darren | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 141067760001 | ||||||||
COOPER, Geoffrey Ian | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | None | 187655820001 | ||||||||
COULTHARD, Graeme Snowdon | Administrateur | Paternoster Square EC4M 7DX London Warwick Court United Kingdom | England | British | Fund Manager | 79010890002 | ||||||||
HAYES, Richard John | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | None | 187573030001 | ||||||||
HUBBARD, Karen Rachael | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Company Director | 164674110001 | ||||||||
LANE, Nathan | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British,American | Director | 237353380001 | ||||||||
LEE, Kristian Brian | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Director | 160887440001 | ||||||||
MCCRUDDEN, Paul | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 193288970001 | ||||||||
MORLEY, Octavia Kate | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | None | 78533480001 | ||||||||
STEAD, David Anthony | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | None | 92764940001 | ||||||||
WHITESIDE, Roger Mark | Administrateur | Brunel Road 41 Industrial Estate WF2 0XG Wakefield Century House West Yorkshire | England | British | Director | 128819260001 |
CARD FACTORY PLC a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 26 avr. 2024 Livré le 26 avr. 2024 | En cours | ||
Brève description Not applicable. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 20 avr. 2022 Livré le 25 avr. 2022 | En cours | ||
Brève description The intellectual property being getting personal device registration number 2496349B, the and the other intellectual property specified in the instrument for more details, please refer to the instrument. The real property at unit I, brunel road, wakefield 41 industrial estate, wakefield with title number WYK742225, the and the other real property specified in the instrument for more details, please refer to the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 20 mai 2021 Livré le 28 mai 2021 | En cours | ||
Brève description The intellectual property being 3 2 1 cards, registration number 2395838 and other intellectual property specified in the instrument. For more details, please see the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0