MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 10355616 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
Adresse du siège social | The Lawn 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 août 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 sept. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 août 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Madhu Ranganathan en tant que directeur le 27 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 21 juin 2024
| 3 pages | SH01 | ||
Comptes annuels établis au 30 juin 2023 | 31 pages | AA | ||
État du capital après une attribution d'actions au 29 mars 2024
| 3 pages | SH01 | ||
Période comptable précédente raccourcie du 31 oct. 2023 au 30 juin 2023 | 1 pages | AA01 | ||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2022 | 32 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Micro Focus Mhc Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Entco Foreign Holdco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Entco Foreign Holdco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept. 2017 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Micro Focus International Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Michael Fernando Acedo en tant qu'administrateur le 31 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Madhu Ranganathan en tant qu'administrateur le 31 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Charlotte Redcliffe en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mark Kenneth Wilkinson en tant qu'administrateur le 31 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Rupert Michael Henry Green en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Christian Waida en tant qu'administrateur le 31 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ian Simmons en tant que directeur le 18 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Charlotte Redcliffe en tant qu'administrateur le 10 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2021 | 33 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Rupert Michael Henry Green en tant qu'administrateur le 30 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jane Caroline Grantham Smithard en tant que directeur le 30 juin 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEDO, Michael Fernando | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | Canada | Canadian | Evp, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 305229620001 | ||||
WAIDA, Christian | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | German | Svp & General Counsel, Commercial Operations | 210176240001 | ||||
WILKINSON, Mark Kenneth | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | British | Svp, Sales - Ecs Europe | 294482840001 | ||||
BANSAL, Sharad | Administrateur | Cowley Park Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Cambridge Business Park Cambridgeshire England | England | Indian | Finance Director | 231460520001 | ||||
CASHMAN, Barry Gareth | Administrateur | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Sales Director | 141815860001 | ||||
GARRETT, Michael John | Administrateur | Cain Road Amen Corner RG12 1HN Bracknell Entcorp Uk Ltd United Kingdom | England | British | Managing Director | 233416010001 | ||||
GREEN, Rupert Michael Henry | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | England | British | Executive | 297494620001 | ||||
HAMANI-SAMAAN, Miral | Administrateur | Cain Road Amen Corner RG12 1HN Bracknell Entcorp Uk Ltd United Kingdom | Switzerland | French | Director | 244575520001 | ||||
RANGANATHAN, Madhu | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United States | American | Evp & Chief Financial Officer | 305151800001 | ||||
REDCLIFFE, Charlotte | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | British | Head Of Tax | 78218030002 | ||||
SIMMONS, Ian | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | England | English | Vice President And General Manager - Uk & Ireland | 282418960001 | ||||
SMITHARD, Jane Caroline Grantham | Administrateur | 22 - 30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | British | Group General Counsel & Company Secretary | 208035540001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Focus Mhc Limited | 30 oct. 2018 | Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn, 22-30 Berkshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Entco Foreign Holdco Limited | 01 sept. 2017 | Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn, 22-30 Berkshire England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Micro Focus International Plc | 01 sept. 2017 | Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | 01 sept. 2016 | Orange Street Wilmington New Castle 120 Delaware Usa | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
01 sept. 2016 | 01 sept. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0