J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.

J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Société étrangère
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueSociété étrangère
    Numéro de société FC010020
    JuridictionRoyaume-Uni
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?

    Adresse du siège social
    270 Park Avenue
    New York
    New York Ny10017
    United States
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MORGAN GUARANTY LIMITED27 juin 197927 juin 1979

    Quels sont les derniers comptes de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. est une société étrangère

    Exigences comptables pour les sociétés étrangères
    Type de comptes étrangersLes règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas
    Conditions de publication des comptesDate de référence comptable attribuée par Companies House
    Activité commercialeSecurities Business & Arranging Interest Rate Swaps
    Forme juridiqueLimited Liability
    Est un établissement de crédit ou financierNon
    Régie parState Of Delaware, Usa
    Pays d'origine du registreUNITED STATES
    Lieu d'enregistrementOffice Of Secretary Of State, State Of Delaware
    Numéro de sociétéN/A

    Quels sont les derniers dépôts pour J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Fermeture de l'établissement(s) britannique(s) BR001994 et de la société étrangère FC010020 le 26 mai 2017

    2 pagesOSDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Timothy James Osborne Throsby en tant que directeur le 05 sept. 2016

    2 pagesOSTM01

    Nomination de David Alan Thompson en tant que personne autorisée à accepter les notifications pour l'établissement au Royaume-Uni BR001994 le 26 févr. 2016.

    2 pagesOSAP07

    Cessation de la nomination pour un établissement du Royaume-Uni - Transaction OSTM03- BR001994 Person Authorised to Accept terminated 26/02/2016 yeng yeng maxwell

    2 pagesOSTM03

    Nomination de Abdelfater Belbachir en tant qu'administrateur le 14 déc. 2015

    3 pagesOSAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jason Edwin Sippel le 08 janv. 2016

    3 pagesOSCH03

    Nomination de Christopher Louis Berthe en tant qu'administrateur le 14 déc. 2015

    3 pagesOSAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy James Osborne Throsby le 01 sept. 2014

    3 pagesOSCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jason Sippel le 01 sept. 2015

    3 pagesOSCH03

    Nomination de Paul Francis Brannan en tant qu'administrateur le 15 déc. 2015

    3 pagesOSAP01

    Modification des documents constitutifs" le 05 août 2010

    18 pagesOSCC01

    Détails modifiés pour une société étrangère - Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Usa

    4 pagesOSCH02

    Cessation de la nomination de Mary Frances Vance en tant que secrétaire le 14 déc. 2015

    2 pagesOSTM02

    Cessation de la nomination de Yeng Yeng Maxwell en tant que secrétaire le 14 déc. 2015

    2 pagesOSTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Horner en tant que directeur le 17 avr. 2015

    2 pagesOSTM01

    Nomination de Jeffrey Lipman en tant que secrétaire le 13 févr. 2015

    3 pagesOSAP03

    Cessation de la nomination de Carlos Hernandez en tant que directeur le 03 oct. 2014

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Colleen Anne Meade en tant que secrétaire le 01 déc. 2008

    2 pagesOSTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrea Angelone en tant que directeur

    2 pagesOSTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Nomination de Yeng Yeng Maxwell en tant que personne autorisée à accepter les notifications pour l'établissement au Royaume-Uni BR001994 le 06 juil. 2012.

    2 pagesOSAP07

    Qui sont les dirigeants de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LIPMAN, Jeffrey
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Uk
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Uk
    British195536750001
    BELBACHIR, Abdelfater
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Ney York United States Of AmericaFrench205119510001
    BERTHE, Christopher Louis
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    New York United States Of AmericaAmerican204669420001
    BRANNAN, Paul Francis
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Connecticut United States Of AmericaBritish92879690002
    SIPPEL, Jason Edwin
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United KingdomBritish149482060002
    BERRY, James Clifford Pierce
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Secrétaire
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    American79713580002
    LAWSON, Jane Elizabeth
    2a Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    Secrétaire
    2a Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    British47291860001
    MAXWELL, Yeng Yeng
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British66736370004
    MEADE, Colleen Anne
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British116239730001
    SAMSON, Timothy Hugh
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Secrétaire
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    American97409050002
    SZYPULA, Richard Michael
    2 Hobart Street
    FOREIGN Bronxville
    Ny 10708
    Usa
    Secrétaire
    2 Hobart Street
    FOREIGN Bronxville
    Ny 10708
    Usa
    Usa30009470001
    VANCE, Mary Frances
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British96140800001
    ANGELONE, Andrea Giovanni
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Italian98441580003
    BRANDOW, Paul
    135 East. 74th St.,Apt.5b
    New York
    Ny
    10021
    Usa
    Administrateur
    135 East. 74th St.,Apt.5b
    New York
    Ny
    10021
    Usa
    Usa92167650001
    BRETT, James
    16 Birch Lane
    Greenwich
    Ct 06830
    Usa
    Administrateur
    16 Birch Lane
    Greenwich
    Ct 06830
    Usa
    American93166600001
    CHRISTIAN JEAN LOUIS, Dalban
    5 Courtfield Mews
    SW5 0NH London
    Administrateur
    5 Courtfield Mews
    SW5 0NH London
    French76710380002
    COLAS, Oliver
    58 Chelsea Park Gardens
    SW3 London
    Administrateur
    58 Chelsea Park Gardens
    SW3 London
    French47291830001
    CORRIE, John Richard Duncan
    Sullingstead
    Hascombe Road
    GU8 4AE Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Sullingstead
    Hascombe Road
    GU8 4AE Godalming
    Surrey
    EnglandBritish80720100001
    DELUCA, John Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    UsaAmerican149482670001
    ENTHOVEN, Michael
    60 Otter Rock Drive
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Administrateur
    60 Otter Rock Drive
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Dutch31709610001
    GRAY, Robert Blackburn
    9 St Simons Avenue
    SW15 6DU London
    Administrateur
    9 St Simons Avenue
    SW15 6DU London
    EnglandBritish26727060001
    GUBERT, Walter Alexander
    14 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Administrateur
    14 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Italian28886800001
    HENDRICKS, Maureen Agnes
    33 Lansdowne Road
    W11 2LQ London
    Administrateur
    33 Lansdowne Road
    W11 2LQ London
    American47292200001
    HERNANDEZ, Carlos
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    American93166670001
    HORNER, John
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    United StatesAmerican170579190001
    LONG, David Nicholas
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Administrateur
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    British98441570003
    LOWE, Claus
    16 Marryat Road
    SW19 5BD Wimbledon
    London
    Administrateur
    16 Marryat Road
    SW19 5BD Wimbledon
    London
    German47292190002
    LYALL, Ian Robert
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Administrateur
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    EnglandBritish181859690001
    MAYER, JR, John Anton
    7 Upland Drive
    Greenwich
    Connecticut 06831
    Usa
    Administrateur
    7 Upland Drive
    Greenwich
    Connecticut 06831
    Usa
    American47291850001
    MEIER, Marcus
    109 Bank Street
    New York
    New York 10014
    Usa
    Administrateur
    109 Bank Street
    New York
    New York 10014
    Usa
    Swiss47292180001
    MOSES, Menasey Marc
    Nw4
    Administrateur
    Nw4
    British68184260001
    PATTERSON, Michael Ellmore
    530 East 86th Street
    10021 New York
    New York 10028
    Usa
    Administrateur
    530 East 86th Street
    10021 New York
    New York 10028
    Usa
    American47292170001
    PINILLA, Juan-Carlos
    75e 75th Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Administrateur
    75e 75th Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Spanish92629140001
    SAIER, George Arnaud
    46 Holland Street
    W8 4LX London
    Administrateur
    46 Holland Street
    W8 4LX London
    French102990210001
    THROSBY, Timothy James Osborne
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    EnglandAustralian170579950001

    J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Securities pledge agreement
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 09 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The securities pledge agreement creates security over the 'pledged collateral'. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trust National Association
    Transactions
    • 09 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 09 janv. 1992
    Livré le 14 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All shares,stock and other securities of any description for the time being desinated by the stock exchange as talisman securities time to time registered in the name of or comprised in a transfer of any nominee company (see form 395 document m 30C for full details.).
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited.
    Transactions
    • 14 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 31 mars 1988
    Livré le 08 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge all sums from time to time deposited by the company.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 08 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1988
    Livré le 08 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company morgan guaranty trust company of new york under or in respect of the "secured sums" (as defined in the terms of the charge
    Brèves mentions
    All rights,claims and interests of the company in and to the stocks/shares (please see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 08 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0