J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.
Vue d'ensemble
| Nom de la société | J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Société étrangère |
| Numéro de société | FC010020 |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?
| Adresse du siège social | 270 Park Avenue New York New York Ny10017 United States |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. est une société étrangère
| Exigences comptables pour les sociétés étrangères | |
|---|---|
| Type de comptes étrangers | Les règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas |
| Conditions de publication des comptes | Date de référence comptable attribuée par Companies House |
| Activité commerciale | Securities Business & Arranging Interest Rate Swaps |
| Forme juridique | Limited Liability |
| Est un établissement de crédit ou financier | Non |
| Régie par | State Of Delaware, Usa |
| Pays d'origine du registre | UNITED STATES |
| Lieu d'enregistrement | Office Of Secretary Of State, State Of Delaware |
| Numéro de société | N/A |
Quels sont les derniers dépôts pour J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Fermeture de l'établissement(s) britannique(s) BR001994 et de la société étrangère FC010020 le 26 mai 2017 | 2 pages | OSDS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Timothy James Osborne Throsby en tant que directeur le 05 sept. 2016 | 2 pages | OSTM01 | ||
Nomination de David Alan Thompson en tant que personne autorisée à accepter les notifications pour l'établissement au Royaume-Uni BR001994 le 26 févr. 2016. | 2 pages | OSAP07 | ||
Cessation de la nomination pour un établissement du Royaume-Uni - Transaction OSTM03- BR001994 Person Authorised to Accept terminated 26/02/2016 yeng yeng maxwell | 2 pages | OSTM03 | ||
Nomination de Abdelfater Belbachir en tant qu'administrateur le 14 déc. 2015 | 3 pages | OSAP01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jason Edwin Sippel le 08 janv. 2016 | 3 pages | OSCH03 | ||
Nomination de Christopher Louis Berthe en tant qu'administrateur le 14 déc. 2015 | 3 pages | OSAP01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy James Osborne Throsby le 01 sept. 2014 | 3 pages | OSCH03 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jason Sippel le 01 sept. 2015 | 3 pages | OSCH03 | ||
Nomination de Paul Francis Brannan en tant qu'administrateur le 15 déc. 2015 | 3 pages | OSAP01 | ||
Modification des documents constitutifs" le 05 août 2010 | 18 pages | OSCC01 | ||
Détails modifiés pour une société étrangère - Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Usa | 4 pages | OSCH02 | ||
Cessation de la nomination de Mary Frances Vance en tant que secrétaire le 14 déc. 2015 | 2 pages | OSTM02 | ||
Cessation de la nomination de Yeng Yeng Maxwell en tant que secrétaire le 14 déc. 2015 | 2 pages | OSTM02 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 16 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de John Horner en tant que directeur le 17 avr. 2015 | 2 pages | OSTM01 | ||
Nomination de Jeffrey Lipman en tant que secrétaire le 13 févr. 2015 | 3 pages | OSAP03 | ||
Cessation de la nomination de Carlos Hernandez en tant que directeur le 03 oct. 2014 | 2 pages | OSTM01 | ||
Cessation de la nomination de Colleen Anne Meade en tant que secrétaire le 01 déc. 2008 | 2 pages | OSTM02 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 16 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 17 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Andrea Angelone en tant que directeur | 2 pages | OSTM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 16 pages | AA | ||
Nomination de Yeng Yeng Maxwell en tant que personne autorisée à accepter les notifications pour l'établissement au Royaume-Uni BR001994 le 06 juil. 2012. | 2 pages | OSAP07 | ||
Qui sont les dirigeants de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPMAN, Jeffrey | Secrétaire | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 Uk | British | 195536750001 | ||||||
| BELBACHIR, Abdelfater | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | Ney York United States Of America | French | 205119510001 | |||||
| BERTHE, Christopher Louis | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | New York United States Of America | American | 204669420001 | |||||
| BRANNAN, Paul Francis | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | Connecticut United States Of America | British | 92879690002 | |||||
| SIPPEL, Jason Edwin | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | United Kingdom | British | 149482060002 | |||||
| BERRY, James Clifford Pierce | Secrétaire | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | American | 79713580002 | ||||||
| LAWSON, Jane Elizabeth | Secrétaire | 2a Lee Terrace Blackheath SE3 9TZ London | British | 47291860001 | ||||||
| MAXWELL, Yeng Yeng | Secrétaire | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 66736370004 | ||||||
| MEADE, Colleen Anne | Secrétaire | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 116239730001 | ||||||
| SAMSON, Timothy Hugh | Secrétaire | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | American | 97409050002 | ||||||
| SZYPULA, Richard Michael | Secrétaire | 2 Hobart Street FOREIGN Bronxville Ny 10708 Usa | Usa | 30009470001 | ||||||
| VANCE, Mary Frances | Secrétaire | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 96140800001 | ||||||
| ANGELONE, Andrea Giovanni | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | Italian | 98441580003 | ||||||
| BRANDOW, Paul | Administrateur | 135 East. 74th St.,Apt.5b New York Ny 10021 Usa | Usa | 92167650001 | ||||||
| BRETT, James | Administrateur | 16 Birch Lane Greenwich Ct 06830 Usa | American | 93166600001 | ||||||
| CHRISTIAN JEAN LOUIS, Dalban | Administrateur | 5 Courtfield Mews SW5 0NH London | French | 76710380002 | ||||||
| COLAS, Oliver | Administrateur | 58 Chelsea Park Gardens SW3 London | French | 47291830001 | ||||||
| CORRIE, John Richard Duncan | Administrateur | Sullingstead Hascombe Road GU8 4AE Godalming Surrey | England | British | 80720100001 | |||||
| DELUCA, John Charles | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 | Usa | American | 149482670001 | |||||
| ENTHOVEN, Michael | Administrateur | 60 Otter Rock Drive Greenwich Connecticut 06830 Usa | Dutch | 31709610001 | ||||||
| GRAY, Robert Blackburn | Administrateur | 9 St Simons Avenue SW15 6DU London | England | British | 26727060001 | |||||
| GUBERT, Walter Alexander | Administrateur | 14 Edwardes Square W8 6HE London | Italian | 28886800001 | ||||||
| HENDRICKS, Maureen Agnes | Administrateur | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | American | 47292200001 | ||||||
| HERNANDEZ, Carlos | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | American | 93166670001 | ||||||
| HORNER, John | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | United States | American | 170579190001 | |||||
| LONG, David Nicholas | Administrateur | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | British | 98441570003 | ||||||
| LOWE, Claus | Administrateur | 16 Marryat Road SW19 5BD Wimbledon London | German | 47292190002 | ||||||
| LYALL, Ian Robert | Administrateur | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | England | British | 181859690001 | |||||
| MAYER, JR, John Anton | Administrateur | 7 Upland Drive Greenwich Connecticut 06831 Usa | American | 47291850001 | ||||||
| MEIER, Marcus | Administrateur | 109 Bank Street New York New York 10014 Usa | Swiss | 47292180001 | ||||||
| MOSES, Menasey Marc | Administrateur | Nw4 | British | 68184260001 | ||||||
| PATTERSON, Michael Ellmore | Administrateur | 530 East 86th Street 10021 New York New York 10028 Usa | American | 47292170001 | ||||||
| PINILLA, Juan-Carlos | Administrateur | 75e 75th Street New York Ny 10021 Usa | Spanish | 92629140001 | ||||||
| SAIER, George Arnaud | Administrateur | 46 Holland Street W8 4LX London | French | 102990210001 | ||||||
| THROSBY, Timothy James Osborne | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | England | Australian | 170579950001 |
J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Securities pledge agreement | Créé le 23 déc. 2003 Livré le 09 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The securities pledge agreement creates security over the 'pledged collateral'. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 09 janv. 1992 Livré le 14 janv. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All shares,stock and other securities of any description for the time being desinated by the stock exchange as talisman securities time to time registered in the name of or comprised in a transfer of any nominee company (see form 395 document m 30C for full details.). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 31 mars 1988 Livré le 08 avr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed charge all sums from time to time deposited by the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 31 mars 1988 Livré le 08 avr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company morgan guaranty trust company of new york under or in respect of the "secured sums" (as defined in the terms of the charge | |
Brèves mentions All rights,claims and interests of the company in and to the stocks/shares (please see form 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0