J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC

J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Société étrangère
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété étrangère
    Numéro de société FC012906
    Numéro d'enregistrement externeN/A
    JuridictionRoyaume-Uni
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC ?

    Adresse du siège social
    Corporation Trust Center
    1209 Orange Street
    Wilmington
    New Castle, Delaware 19801
    United States
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2022
    Date d'échéance des prochains comptes
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC est une société étrangère

    Exigences comptables pour les sociétés étrangères
    Type de comptes étrangersLes règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas
    Conditions de publication des comptesDate de référence comptable attribuée par Companies House
    Activité commercialeEngage In Any Lawful Activity
    Forme juridiquePublic Company Ltd By Shares
    Est un établissement de crédit ou financierNon
    Régie parGeneral Corp. Laws Of Delaware
    Pays d'origine du registreUNITED STATES
    Lieu d'enregistrementOffice Of Sec Of State Delaware
    Numéro de sociétéN/A

    Quels sont les derniers dépôts pour J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Craig Michael Sullivan en tant qu'administrateur le 13 févr. 2020

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Michael John O'brien en tant que directeur le 03 mai 2020

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Scott Edward Richter en tant que secrétaire le 02 déc. 2021

    2 pagesOSTM02

    Nomination de Scott Edward Richter en tant que secrétaire le 15 mai 2007

    3 pagesOSAP03

    Cessation de la nomination de Lawrence Unrein en tant que directeur le 31 janv. 2021

    2 pagesOSTM01

    Nomination de Katherine Gail Manghillis en tant que secrétaire le 02 déc. 2021

    3 pagesOSAP03

    Nomination de Andrea Lynn Lisher en tant qu'administrateur le 03 mars 2021

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Michael Alan Camacho en tant que directeur le 03 mars 2021

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Megan Ann Mcclellan en tant que directeur le 13 févr. 2020

    2 pagesOSTM01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2019

    26 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020

    26 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021

    27 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2018

    24 pagesAA

    Nomination de Michael Alan Camacho en tant qu'administrateur le 04 janv. 2017

    4 pagesOSAP01

    Nomination de Megan Ann Mcclellan en tant qu'administrateur le 04 janv. 2017

    3 pagesOSAP01

    Nomination de Anton Pil en tant qu'administrateur le 04 janv. 2017

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Yeng Yeng Maxwell en tant que secrétaire le 18 déc. 2018

    2 pagesOSTM02

    Cessation de la nomination de Robert Lynn Young en tant que directeur le 21 juil. 2016

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Douglas Clark Wurth en tant que directeur le 31 déc. 2015

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Craig Michael Sullivan en tant que directeur le 04 janv. 2017

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Jedediah Isiah Laskowitz en tant que directeur le 31 déc. 2017

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Joseph Kenneth Azelby en tant que directeur le 04 janv. 2017

    2 pagesOSTM01

    Détails modifiés pour une société étrangère - 270 Park Avenue, New York, New York 10017, United States

    4 pagesOSCH02

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2017

    26 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2016

    26 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de J P MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MANGHILLIS, Katherine Gail
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    299273500001
    DONOHUE, John
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United StatesAmerican198696040001
    DOWD, Joy
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United StatesAmerican198696140001
    GATCH, George
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British86343740003
    LISHER, Andrea Lynn
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    United StatesAmerican299226560001
    MICHELE, Robert Charles
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United StatesAmerican198820020001
    PIL, Anton
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United StatesAmerican255613000001
    POWELL, Andrew
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Unitd States Of AmericaBritish198961140001
    QUINSEE, Paul Anthony
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British113671600002
    SULLIVAN, Craig Michael
    Bank Street
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    E14 5JP London
    25
    United StatesBritish299404840001
    ANSELMI, Robert Anthony
    2 Pine Island Road
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    Secrétaire
    2 Pine Island Road
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    American46110530001
    BARABAS, Kathleen
    163 West 17th St
    New York
    Ny 10011
    Usa
    Secrétaire
    163 West 17th St
    New York
    Ny 10011
    Usa
    British97573200001
    BERRY, James Clifford Pierce
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Secrétaire
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    American79713580002
    BRAVERMAN, William
    32 Axtell Drive
    Scarsdale
    Ny 10583
    Usa
    Secrétaire
    32 Axtell Drive
    Scarsdale
    Ny 10583
    Usa
    British97579200001
    CASAZZA, Melissa
    42-30 Douglaston Parkway, Apt 3p
    Douglaston
    Ny 11363
    Secrétaire
    42-30 Douglaston Parkway, Apt 3p
    Douglaston
    Ny 11363
    British97580260001
    CHE, Seow
    Block 498d
    Tampines Street 45, 405-382
    FOREIGN Singapore 522498
    Republic Of Singapore
    Secrétaire
    Block 498d
    Tampines Street 45, 405-382
    FOREIGN Singapore 522498
    Republic Of Singapore
    British82134950001
    CLEMENTS, Elaine Joy
    17 Uphill Road
    NW7 4RA London
    Secrétaire
    17 Uphill Road
    NW7 4RA London
    British68375200001
    DELLA PIETRA, Anthony
    400 E. 84th Street
    Apartment 41-A
    New York Ny 10028
    United
    Secrétaire
    400 E. 84th Street
    Apartment 41-A
    New York Ny 10028
    United
    Usa60310740001
    DOYLE, John F
    75-02 Ashurst
    Forest Hill
    Nj 11375
    Usa
    Secrétaire
    75-02 Ashurst
    Forest Hill
    Nj 11375
    Usa
    British82261370001
    GALLANT, Bruce
    363 Stiles Court
    West Orange
    Nj 07052
    Usa
    Secrétaire
    363 Stiles Court
    West Orange
    Nj 07052
    Usa
    British82134910001
    HANEN, Allen Harvey
    38 King Henrys Road
    NW3 3RP London
    Secrétaire
    38 King Henrys Road
    NW3 3RP London
    British52084220001
    KHAZANEH, Leila
    25 Hans Place
    SW1X 0JY London
    Secrétaire
    25 Hans Place
    SW1X 0JY London
    British81562410001
    LOGSON, Marianne
    800 5th Avenue, Apt. 10c
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Secrétaire
    800 5th Avenue, Apt. 10c
    New York
    Ny 10021
    Usa
    British97579190001
    MAXWELL, Yeng Yeng
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    British66736370004
    RICHTER, Scott Edward
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    299275020001
    SAMSON, Timothy Hugh
    168 Sterling Pl 3r
    Brooklyn
    New York
    Ny 11217
    Usa
    Secrétaire
    168 Sterling Pl 3r
    Brooklyn
    New York
    Ny 11217
    Usa
    American97409050001
    SCIBETTA, Paul Louis
    43 Princedale Road
    W11 4NP London
    Secrétaire
    43 Princedale Road
    W11 4NP London
    British65494880001
    SOJKA, Sandra
    3 Woodland Avenue
    Matawan
    Nj 07747
    Usa
    Secrétaire
    3 Woodland Avenue
    Matawan
    Nj 07747
    Usa
    British82134940001
    WEBB, Frank
    77 Park Avenue \9g
    New York
    Ny 10016
    Usa
    Secrétaire
    77 Park Avenue \9g
    New York
    Ny 10016
    Usa
    British82134930001
    YONG, Chee Ram
    19 Eastwood Place
    FOREIGN Singapore 486579
    Republic Of Singapore
    Secrétaire
    19 Eastwood Place
    FOREIGN Singapore 486579
    Republic Of Singapore
    British82134920001
    ANDERSON, Keith Warren
    7 Wilton Place
    SW1X 8RH London
    Administrateur
    7 Wilton Place
    SW1X 8RH London
    American46110520001
    ANSELMI, Robert Anthony
    2 Pine Island Road
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    Administrateur
    2 Pine Island Road
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    American46110530001
    AZELBY, Joseph Kenneth
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British113811840002
    BERNSTEIN, Seth Perry
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Administrateur
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British113671610002
    BRODERICK, James Baldridge, Mr.
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United KingdomAmerican58458580002

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0