NORSE IRISH FERRIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Société étrangère
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORSE IRISH FERRIES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété étrangère
    Numéro de société FC017751
    Numéro d'enregistrement externe55360
    JuridictionRoyaume-Uni
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe NORSE IRISH FERRIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor St Mary's Court
    20 Hill Street
    IM1 1EU Douglas
    Isle Of Man
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NORSE IRISH FERRIES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2019
    Date d'échéance des prochains comptes
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    NORSE IRISH FERRIES LIMITED est une société étrangère

    Exigences comptables pour les sociétés étrangères
    Type de comptes étrangersLes règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas
    Conditions de publication des comptesDate de référence comptable attribuée par Companies House
    Activité commercialeFerry Operating Company
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Est un établissement de crédit ou financierNon
    Régie parThe Isle Of Man Companies Act 1931-1993
    Pays d'origine du registreISLE OF MAN
    Lieu d'enregistrementIsle Of Man Companies Register
    Numéro de société55360

    Quels sont les derniers dépôts pour NORSE IRISH FERRIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Détails modifiés pour une société étrangère - Merchants House 24 North Quay, Douglas, IM1 4LE, Isle of Man

    4 pagesOSCH02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Alan Williamson Hendry en tant que directeur le 11 déc. 2003

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Allister Mulligan en tant que directeur le 14 déc. 2001

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Trevor Leach en tant que directeur le 01 mai 2000

    4 pagesOSTM01

    Nomination de Mr Michael Alan Williamson Hendry en tant qu'administrateur le 01 oct. 1999

    4 pagesOSAP01

    Nomination de Mr Trevor Leach en tant qu'administrateur le 02 oct. 1999

    4 pagesOSAP01

    Nomination de Mr Allister Mulligan en tant qu'administrateur le 18 juin 1996

    4 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Ruth Helen Douthwaite en tant que directeur le 01 oct. 1999

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de David John Frederick John Cooil en tant que directeur le 01 oct. 1999

    4 pagesOSTM01

    Nomination de Ms Ruth Helen Douthwaite en tant qu'administrateur le 15 août 1996

    4 pagesOSAP01

    Nomination de Mr David John Frederick John Cooil en tant qu'administrateur le 30 juin 1995

    4 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Ridgeway Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 03 mai 2013

    2 pagesOSTM02

    Cessation de la nomination de Derek Geoffrey Sloan en tant que directeur le 04 nov. 2005

    4 pagesOSTM01

    Nomination de Mr Derek Geoffrey Sloan en tant qu'administrateur le 11 déc. 2003

    4 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de David John Capps en tant que directeur le 01 oct. 1999

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Philip James Hobson en tant que secrétaire le 30 juin 1995

    4 pagesOSTM02

    Cessation de la nomination de Philip James Hobson en tant que directeur le 30 juin 1995

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Willy Hakon Jahannesen en tant que directeur le 17 juin 1996

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Jan Peter Roed Jr en tant que directeur le 19 mai 1998

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Haydn Edward Brickell en tant que directeur le 11 janv. 1999

    4 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Phillip Stephen Shepherd en tant que directeur le 31 déc. 2011

    2 pagesOSTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Michael Spencer en tant que secrétaire le 02 mai 2000

    4 pagesOSTM02

    Nomination de David Michael Spencer en tant que secrétaire le 01 oct. 1999

    4 pagesOSAP03

    Qui sont les dirigeants de NORSE IRISH FERRIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARLSEN, Torben
    24 North Quay
    IM1 4LE Douglas
    Merchants House
    Isle Of Man
    Administrateur
    24 North Quay
    IM1 4LE Douglas
    Merchants House
    Isle Of Man
    DenmarkDanish251923720001
    ROBDRUP, Kell
    Soevangen 49
    Ishoej
    Dk-2635
    Denmark
    Administrateur
    Soevangen 49
    Ishoej
    Dk-2635
    Denmark
    Danish253389950001
    BRICKELL, Haydn Edward
    North Quay
    Douglas
    Capco House 31/37
    Isle Of Man
    Secrétaire
    North Quay
    Douglas
    Capco House 31/37
    Isle Of Man
    253388800001
    BRICKWELL, Haydn Edward
    Capco 31/37
    North Quay
    Douglas
    Isle Of Man
    Secrétaire
    Capco 31/37
    North Quay
    Douglas
    Isle Of Man
    251928850001
    GREGORY, Robert
    Erica Close
    West End
    GU24 9PE Woking
    10
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Erica Close
    West End
    GU24 9PE Woking
    10
    Surrey
    United Kingdom
    251929410001
    GREGORY, Robert Paul
    Erica Close
    West End
    GU24 9PE Woking
    10
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Erica Close
    West End
    GU24 9PE Woking
    10
    Surrey
    United Kingdom
    253389350001
    HOBSON, Philip James
    10 Christian Close
    Ballastowell Gardens
    ISLE MAN Ramsey
    Isle Of Man
    Secrétaire
    10 Christian Close
    Ballastowell Gardens
    ISLE MAN Ramsey
    Isle Of Man
    English61913120001
    SEWELL, Jeremy Paul
    Lynwood Grove
    BR6 0BH Orpington
    84
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Lynwood Grove
    BR6 0BH Orpington
    84
    Kent
    United Kingdom
    251928670001
    SEWELL, Jeremy Paul
    Lynwood Grove
    BR6 0BH Orpington
    84
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Lynwood Grove
    BR6 0BH Orpington
    84
    Kent
    United Kingdom
    253389480001
    SPENCER, David Michael
    Park Close
    IM4 4HB Glen Vine
    11
    Isle Of Man
    Secrétaire
    Park Close
    IM4 4HB Glen Vine
    11
    Isle Of Man
    252595370001
    SPENCER, David Michael
    Park Close
    IM4 4HB Glen Vine
    11
    Isle Of Man
    Secrétaire
    Park Close
    IM4 4HB Glen Vine
    11
    Isle Of Man
    253392470001
    RIDGEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    Secrétaire
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    Forme juridiqueLIMITED
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleISLE OF MAN
    Numéro d'enregistrement99261C
    251929630001
    RIDGEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Secrétaire
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    253388630001
    BRICKELL, Haydn Edward
    Karin Bach
    Sulby Glen
    Sulby
    Isle Of Man
    Administrateur
    Karin Bach
    Sulby Glen
    Sulby
    Isle Of Man
    British28224840001
    CAPPS, David John
    Second Floor Sir Walter Raleigh House
    48-50 The Esplanade
    CHANNEL St Helier
    Jersey
    Administrateur
    Second Floor Sir Walter Raleigh House
    48-50 The Esplanade
    CHANNEL St Helier
    Jersey
    British75686940002
    COOIL, David John Frederick John
    31/37 North Quay
    Douglas
    Capco House
    Isle Of Man
    Administrateur
    31/37 North Quay
    Douglas
    Capco House
    Isle Of Man
    British255444650001
    DOUTHWAITE, Ruth Helen
    31/37 North Quay
    Douglas
    Capco House
    Isle Of Man
    Administrateur
    31/37 North Quay
    Douglas
    Capco House
    Isle Of Man
    British60807480002
    HENDRY, Michael Alan Williamson
    Marryat Road
    SW19 5BB Wimbledon
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Marryat Road
    SW19 5BB Wimbledon
    23
    United Kingdom
    British255532000001
    HOBSON, Philip James
    10 Christian Close
    Ballastowell Gardens
    ISLE MAN Ramsey
    Isle Of Man
    Administrateur
    10 Christian Close
    Ballastowell Gardens
    ISLE MAN Ramsey
    Isle Of Man
    English61913120001
    JAHANNESEN, Willy Hakon
    Flat 2, Berkeley Court
    Derryvolgie Avenue
    Belfast
    Northern Ireland
    Administrateur
    Flat 2, Berkeley Court
    Derryvolgie Avenue
    Belfast
    Northern Ireland
    Norwegian46291340001
    LEACH, Trevor
    Bradda Road
    Port Erin
    Bradda House
    Isle Of Man
    Administrateur
    Bradda Road
    Port Erin
    Bradda House
    Isle Of Man
    British255531730001
    MULLIGAN, Allister
    West Bank Road
    BT3 9JN Belfast
    Victoria Terminal 2
    Northern Ireland
    Administrateur
    West Bank Road
    BT3 9JN Belfast
    Victoria Terminal 2
    Northern Ireland
    British255531450001
    ROED JR, Jan Peter
    PO BOX 5727
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    PO BOX 5727
    Dubai
    United Arab Emirates
    Norwegian58513540001
    SHEPHERD, Phillip Stephen
    9 Riverside
    West Kirby
    CH48 3JB Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    9 Riverside
    West Kirby
    CH48 3JB Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish109139150001
    SLOAN, Derek Geoffrey
    School Hill
    CH60 0DP Lower Heswell
    3
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    School Hill
    CH60 0DP Lower Heswell
    3
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish109556360001

    NORSE IRISH FERRIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Pledge of shares of northern sound shipping limited
    Créé le 14 mai 1996
    Livré le 28 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness due or to become due from the company to the bank under a isda master agreement and attached schedules of even date ("the swap documents"); to the bank and bank or ireland ("the lenders"), loans of us$6,250,000 and £2,500,000 and all other indebtedness under a loan agreement of even date and the security documents (as defined); and to the bank, the lenders and the bank, the performance and observance of the compliance with all covenants, agreements, conditions and provisions expressed or implied on the part of northern sound shipping limited to be performed, observed or complied with under the loan agreement, the swap documents and the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    Two ordinary shares of £1 each in the isle of man company northern sound shipping limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 28 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 mai 1996
    Livré le 28 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a guarantee of even date (as from time to time amended or supplemented)
    Brèves mentions
    .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 28 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NORSE IRISH FERRIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2003Administration discharged
    20 févr. 2003Administration started
    Administration order
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Shagun Sunil Dubey
    Ernst & Young Llp
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    Michael David Rollings
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    practitioner
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    2
    DateType
    04 nov. 2003Date of meeting to approve CVA
    22 mars 2006Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael David Rollings
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0