PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED

PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Société étrangère
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueSociété étrangère
    Numéro de société FC021877
    Numéro d'enregistrement externeCR 89715
    JuridictionRoyaume-Uni
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Maples And Calder
    Ugland House PO BOX 309
    George Town
    Grand Cayman Cayman Islands
    Cayman Islands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 août 2021

    PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED est une société étrangère

    Exigences comptables pour les sociétés étrangères
    Type de comptes étrangersLes règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas
    Conditions de publication des comptesDate de référence comptable attribuée par Companies House
    Activité commercialeToissue Debt Securities & On-Lend Proceeds
    Forme juridiqueExempt Company Withg Limited Liability
    Est un établissement de crédit ou financierNon
    Régie parCayman Islands
    Pays d'origine du registreCAYMAN ISLANDS
    Lieu d'enregistrementRegister Of Cayman Islands Companies
    Numéro de sociétéCR 89715

    Quels sont les derniers dépôts pour PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Fermeture de l'établissement(s) britannique(s) BR005024 et de la société étrangère FC021877 le 27 mars 2023

    3 pagesOSDS01

    Cessation de la nomination de Francesca Ann Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022

    2 pagesOSTM02

    Comptes annuels établis au 15 août 2021

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Daniel Jonathan Wynne en tant que directeur le 30 juin 2021

    2 pagesOSTM01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    3 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 16 août 2020

    21 pagesAA

    Comptes annuels établis au 18 août 2019

    22 pagesAA

    Comptes annuels établis au 19 août 2018

    22 pagesAA

    Comptes annuels établis au 19 août 2017

    25 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daniel Jonathan Wynne le 05 déc. 2017

    3 pagesOSCH03

    Nomination de Mr Daniel Jonathan Wynne en tant qu'administrateur le 21 avr. 2017

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Mark Howard Filer en tant que directeur le 21 avr. 2017

    2 pagesOSTM01

    Comptes annuels établis au 22 août 2016

    24 pagesAA

    Comptes annuels établis au 22 août 2015

    23 pagesAA

    Comptes annuels établis au 23 août 2014

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wilmington Trust Sp Services (London) Limited en tant que directeur le 09 oct. 2014

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Dean Edward John Merritt en tant que directeur le 08 oct. 2014

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Claire Louise Harris en tant que secrétaire le 07 oct. 2014

    2 pagesOSTM02

    Nomination de Francesca Ann Appleby en tant que secrétaire le 07 oct. 2014

    3 pagesOSAP03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesOSAP01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesOSAP01

    Comptes annuels établis au 17 août 2013

    21 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stephen Billingham en tant que directeur

    2 pagesOSTM01

    Qui sont les dirigeants de PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    APPLEBY, Francesca Ann
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    British191946720001
    ARMITAGE, Helen Tyrrell
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    British166847910001
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    British175820210001
    RUDD, Susan Clare
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    British81789210002
    STEWART, Claire Susan
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    British117216940001
    BILLINGHAM, Stephen Robert
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    UkBritish163365820001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Administrateur
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    United KingdomBritish141395280001
    FILER, Mark Howard
    c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited
    1 Kings Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited
    1 Kings Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish108927600003
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MERRITT, Dean Edward John
    c/o Talbot Highes Mckillop Llp
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Talbot Highes Mckillop Llp
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    United Kingdom
    United KingdomBritish141247230001
    PRESTON, Neil David
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    Administrateur
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    United KingdomBritish63043630002
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Administrateur
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritish141561650001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritish81928120001
    TURNBULL, Ronald
    16 Willow Road
    Dairy Lane Estate
    DH4 5QF Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Administrateur
    16 Willow Road
    Dairy Lane Estate
    DH4 5QF Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British63331360001
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Administrateur
    Second Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    EnglandBritish128819260001
    WYNNE, Daniel Jonathan
    c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited
    1 King's Arm Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    Administrateur
    c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited
    1 King's Arm Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    EnglandBritish101879110005
    WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED
    King's Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor 1
    Administrateur
    King's Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor 1
    24311810024

    PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    The eighth supplemental issuer deed of charge
    Créé le 01 août 2005
    Livré le 12 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title, interest and benefit, present and future, in, to and under the second new notes subscription agreement, the seventh supplemental punch taverns b deed of charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited (The Issuer Security Trustee)
    Transactions
    • 12 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Seventh supplemental issuer deed of charge
    Créé le 09 mai 2005
    Livré le 10 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit in and to all moneys standing to the credit of the issuer transaction account, the issuer cash collateral account and the prefunding account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited (The Issuer Security Trustee and Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 10 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Second supplemental issuer deed of charge made between the company, bankers trustee company limited and deutsche bank international trust co. (Jersey) limited (the note trustee)
    Créé le 23 déc. 1999
    Livré le 12 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) under the second supplemental deed of charge
    Brèves mentions
    All rights title interest and benefit present and future in to and under the supplemental pubmaster deed of charge including all rights to receive payment of any amounts which may become payable to the issuer thereunder and all payments received by the issuer thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited
    Transactions
    • 12 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0