PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la soci été | PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Société étrangère |
| Numéro de société | FC021877 |
| Numéro d'enregistrement externe | CR 89715 |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?
| Adresse du siège social | Maples And Calder Ugland House PO BOX 309 George Town Grand Cayman Cayman Islands Cayman Islands |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 15 août 2021 |
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED est une société étrangère
| Exigences comptables pour les sociétés étrangères | |
|---|---|
| Type de comptes étrangers | Les règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas |
| Conditions de publication des comptes | Date de référence comptable attribuée par Companies House |
| Activité commerciale | Toissue Debt Securities & On-Lend Proceeds |
| Forme juridique | Exempt Company Withg Limited Liability |
| Est un établissement de crédit ou financier | Non |
| Régie par | Cayman Islands |
| Pays d'origine du registre | CAYMAN ISLANDS |
| Lieu d'enregistrement | Register Of Cayman Islands Companies |
| Numéro de société | CR 89715 |
Quels sont les derniers dépôts pour PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Fermeture de l'établissement(s) britannique(s) BR005024 et de la société étrangère FC021877 le 27 mars 2023 | 3 pages | OSDS01 | ||
Cessation de la nomination de Francesca Ann Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022 | 2 pages | OSTM02 | ||
Comptes annuels établis au 15 août 2021 | 22 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Daniel Jonathan Wynne en tant que directeur le 30 juin 2021 | 2 pages | OSTM01 | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 3 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 3 pages | MR04 | ||
Comptes annuels établis au 16 août 2020 | 21 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 18 août 2019 | 22 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 19 août 2018 | 22 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 19 août 2017 | 25 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daniel Jonathan Wynne le 05 déc. 2017 | 3 pages | OSCH03 | ||
Nomination de Mr Daniel Jonathan Wynne en tant qu'administrateur le 21 avr. 2017 | 3 pages | OSAP01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Howard Filer en tant que directeur le 21 avr. 2017 | 2 pages | OSTM01 | ||
Comptes annuels établis au 22 août 2016 | 24 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 22 août 2015 | 23 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 23 août 2014 | 22 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Wilmington Trust Sp Services (London) Limited en tant que directeur le 09 oct. 2014 | 2 pages | OSTM01 | ||
Cessation de la nomination de Dean Edward John Merritt en tant que directeur le 08 oct. 2014 | 2 pages | OSTM01 | ||
Cessation de la nomination de Claire Louise Harris en tant que secrétaire le 07 oct. 2014 | 2 pages | OSTM02 | ||
Nomination de Francesca Ann Appleby en tant que secrétaire le 07 oct. 2014 | 3 pages | OSAP03 | ||
Nomination d'un administrateur | 3 pages | OSAP01 | ||
Nomination d'un administrateur | 3 pages | OSAP01 | ||
Comptes annuels établis au 17 août 2013 | 21 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Stephen Billingham en tant que directeur | 2 pages | OSTM01 | ||
Qui sont les dirigeants de PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| APPLEBY, Francesca Ann | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire | British | 191946720001 | ||||||
| ARMITAGE, Helen Tyrrell | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | British | 166847910001 | ||||||
| CROSS, Anthony | Secrétaire | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | British | 175820210001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 23 Whitehouse Drive WS13 8FE Lichfield Staffordshire | British | 81789210002 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire Uk | British | 117216940001 | ||||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | Uk | British | 163365820001 | |||||
| BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge | Administrateur | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | British | 53682420001 | |||||
| DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire Uk | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FILER, Mark Howard | Administrateur | c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited 1 Kings Arms Yard EC2R 7AF London Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 108927600003 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MERRITT, Dean Edward John | Administrateur | c/o Talbot Highes Mckillop Llp Snow Hill EC1A 2AY London 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 141247230001 | |||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Postern Road Tatenhill DE13 9SJ Burton On Trent 57 Staffordshire | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SANDS, John Robert | Administrateur | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Administrateur | Charlton Manor Ashley Road Charlton Kings GL52 6NS Cheltenham Gloucestershire | Gb-Eng | British | 81928120001 | |||||
| TURNBULL, Ronald | Administrateur | 16 Willow Road Dairy Lane Estate DH4 5QF Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 63331360001 | ||||||
| WHITESIDE, Roger Mark | Administrateur | Second Avenue Centrum One Hundred DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | England | British | 128819260001 | |||||
| WYNNE, Daniel Jonathan | Administrateur | c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited 1 King's Arm Yard EC2R 7AF London Third Floor | England | British | 101879110005 | |||||
| WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED | Administrateur | King's Arms Yard EC2R 7AF London Third Floor 1 | 24311810024 |
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| The eighth supplemental issuer deed of charge | Créé le 01 août 2005 Livré le 12 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right, title, interest and benefit, present and future, in, to and under the second new notes subscription agreement, the seventh supplemental punch taverns b deed of charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Seventh supplemental issuer deed of charge | Créé le 09 mai 2005 Livré le 10 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title interest and benefit in and to all moneys standing to the credit of the issuer transaction account, the issuer cash collateral account and the prefunding account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Second supplemental issuer deed of charge made between the company, bankers trustee company limited and deutsche bank international trust co. (Jersey) limited (the note trustee) | Créé le 23 déc. 1999 Livré le 12 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) under the second supplemental deed of charge | |
Brèves mentions All rights title interest and benefit present and future in to and under the supplemental pubmaster deed of charge including all rights to receive payment of any amounts which may become payable to the issuer thereunder and all payments received by the issuer thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0