KATRINE LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Société étrangère
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKATRINE LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueSociété étrangère
    Numéro de société FC026411
    Numéro d'enregistrement externe91782
    JuridictionRoyaume-Uni
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe KATRINE LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    47 Esplanade
    St Helier
    Jersey
    Je1 Obd
    Channel Islands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KATRINE LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    KATRINE LEASING LIMITED est une société étrangère

    Exigences comptables pour les sociétés étrangères
    Type de comptes étrangersLes règles comptables du pays d'origine ne s'appliquent pas
    Conditions de publication des comptesDate de référence comptable attribuée par Companies House
    Activité commercialeThe Owning, Leasing And/Or Chartering Of Vessels
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Share
    Est un établissement de crédit ou financierNon
    Régie parCompanies (Jersey) Law 1991 (As Amended)
    Pays d'origine du registreCHANNEL ISLANDS
    Lieu d'enregistrementThe Companies Registry, Jersey
    Numéro de société91782

    Quels sont les derniers dépôts pour KATRINE LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Fermeture de l'établissement(s) britannique(s) BR008548 et de la société étrangère FC026411 le 31 août 2019

    2 pagesOSDS01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    3 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Andrew John Kemp en tant que directeur le 02 juil. 2018

    pagesOSTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    17 pagesAA

    Nomination de Alyson Elizabeth Mulholland en tant que secrétaire le 18 déc. 2017

    3 pagesOSAP03

    Cessation de la nomination de Michelle Antoinette Angela Johnson en tant que secrétaire le 18 déc. 2017

    2 pagesOSTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew John Kemp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2017

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Richard Owen Williams en tant que directeur le 19 sept. 2016

    2 pagesOSTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    19 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Simon Gledhill en tant que directeur

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de John Morrissey en tant que directeur

    2 pagesOSTM01

    Cessation de la nomination de Paul Gittens en tant que secrétaire

    2 pagesOSTM02

    Nomination d'un secrétaire

    3 pagesOSAP03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Cumming en tant que directeur

    2 pagesOSTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    20 pagesAA

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesOSAP01

    Cessation de la nomination pour un établissement du Royaume-Uni - Transaction OSTM03- BR008548 Person Authorised to Represent terminated 30/09/2011 lambertus hendrik veldhuizen

    2 pagesOSTM03

    Cessation de la nomination de Lambertus Veldhuizen en tant que directeur

    2 pagesOSTM01

    Qui sont les dirigeants de KATRINE LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MULHOLLAND, Alyson Elizabeth
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Stansfield House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Stansfield House
    United Kingdom
    241675350001
    DOWSETT, Colin Graham
    Aldershot Road
    GU51 3NN Fleet
    26a
    Hampshire
    Administrateur
    Aldershot Road
    GU51 3NN Fleet
    26a
    Hampshire
    EnglandBritish152332230001
    FOX, Gerard Ashley
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    GITTENS, Paul
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    British86496390001
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East Tower House
    Cheshire
    Secrétaire
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East Tower House
    Cheshire
    British181592900001
    CRILLIS SECRETARIES LIMITED
    44 Esplanade
    JE4 8PN St. Helier
    Jersey
    Secrétaire
    44 Esplanade
    JE4 8PN St. Helier
    Jersey
    111877100001
    CARLSSON, Svante Wilhelm
    Terragatan 5
    FOREIGN Se 411 83 Gothenburg
    Sweden
    Administrateur
    Terragatan 5
    FOREIGN Se 411 83 Gothenburg
    Sweden
    SwedenSwedish126524710001
    COWIE, George Albert
    25 Dubford Terrace
    Bridge Of Don
    AB23 8GE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    25 Dubford Terrace
    Bridge Of Don
    AB23 8GE Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish10280510001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United KingdomBritish46297770002
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United KingdomBritish152766650001
    KEMP, Andrew John
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    4th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish222042280001
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritish94094650001
    PERCY, Michael Hugh
    32 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    Administrateur
    32 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    EnglandBritish20962040001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United KingdomDutch152683120001
    WELO, Tom Peter Andreas Wiel
    5 The Policies Dalmuinzie Road
    Bieldside
    AB15 9EB Aberdeen
    Administrateur
    5 The Policies Dalmuinzie Road
    Bieldside
    AB15 9EB Aberdeen
    United KingdomNorwegian45981990003
    WILLIAMS, Richard Owen
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    6th Floor 33
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    6th Floor 33
    England
    EnglandBritish164554190001

    KATRINE LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A first priority dutch ship mortgage
    Créé le 19 janv. 2011
    Livré le 27 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first priority non-possesory right of pledge over each of its related moveable assets; and a non-possesory first priority right of pledge in advance of its future related movebale assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stena Simplon LTD
    Transactions
    • 27 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Lessor proceeds account charge
    Créé le 18 janv. 2011
    Livré le 20 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights, title and interest in and to the interest bearing euro account of the company with svenska handelsbanken ab (publ) london with account number 17723002 and all moneys, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stena Simplon LTD. (Lessee)
    Transactions
    • 20 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 18 janv. 2011
    Livré le 20 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The dutch registered 4,050 lane metre ropax M.V. stena transporter imo number 9469376 and in its equipment and appurtenances see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stena Simplon LTD
    Transactions
    • 20 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Lessor proceeds account charge
    Créé le 31 déc. 2007
    Livré le 17 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The lessor proceeds account moneys and the lessor proceeds account and other related instruments or securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stena Drillmax I Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage re M.V. "stena drillmax"
    Créé le 31 déc. 2007
    Livré le 17 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64 shares in the ship and her appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Stena Drillmax I Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant re M.V. "stena drillmax"
    Créé le 31 déc. 2007
    Livré le 17 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All present and future interest in the ship , total loss proceeds, sale proceeds and any sale proceeds receivable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stena Drillmax I Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A novation of a receivables purchase agreement
    Créé le 01 déc. 2005
    Livré le 19 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights, title and interest in and to its rights under or pursuant to a loan agreement dated 25 november 2005 and its rights to any payments or repayments to be made to the company under such loan agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stena (Switzerland) Ag (the Receivables Purchaser)
    Transactions
    • 19 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0