SCOTTISH SEAFOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Société étrangère
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCOTTISH SEAFOODS LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueSociété étrangère
    Numéro de société NF003102
    JuridictionRoyaume-Uni
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe SCOTTISH SEAFOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Harbour
    Kilkeel
    BT34 4AX Co.Down
    Adresse du siège social non livrableNon

    SCOTTISH SEAFOODS LIMITED est une société étrangère

    Exigences comptables pour les sociétés étrangères
    Type de comptes étrangersLes règles comptables du pays d'origine s'appliquent
    Conditions de publication des comptesLa date de publication des comptes n'a pas besoin d'être fournie par l'entreprise
    Est un établissement de crédit ou financierNon
    Pays d'origine du registreGREAT BRITAIN
    Numéro de sociétéSC118977

    Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH SEAFOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Avis de fermeture d'un établissement

    NF003102 company closed\15/04/2013
    1 pagesLET-CESS

    legacy

    4 pages6421B(NI)

    legacy

    4 pages6421B(NI)

    legacy

    1 pages6421C(NI)

    legacy

    4 pages6421B(NI)

    legacy

    8 pages6421B(NI)

    legacy

    10 pages6421B(NI)

    legacy

    1 pages411A(NI)

    legacy

    1 pages411A(NI)

    Détails d'une hypothèque

    Pars re mortage
    402(NI)

    Détails d'une hypothèque

    Pars re mortage
    8 pages402(NI)

    Détails d'une hypothèque

    Pars re mortage
    402(NI)

    legacy

    1 pages411A(NI)

    legacy

    2 pages411A(NI)

    Détails d'une hypothèque

    Pars re mortage
    9 pages402(NI)

    Détails d'une hypothèque

    Pars re mortage
    6 pages402(NI)

    legacy

    6421B(NI)

    legacy

    6421B(NI)

    Détails d'une hypothèque

    Pars re mortage
    11 pages402(NI)

    legacy

    411A(NI)

    legacy

    411A(NI)

    legacy

    411A(NI)

    legacy

    411A(NI)

    legacy

    5 pages411A(NI)

    legacy

    ACX(NI)

    Qui sont les dirigeants de SCOTTISH SEAFOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKER, Michael
    Humber Lodge
    Old Post Office Lane
    DNI8 6HH South Ferriby
    N. Lincolnshire
    Secrétaire
    Humber Lodge
    Old Post Office Lane
    DNI8 6HH South Ferriby
    N. Lincolnshire
    145596230001
    WILKIN CHAPMAN SECRETARIAL, Ltd
    PO BOX 16 New Oxford House
    Townhall Square
    DN31 1HE Grimsby
    Ne Lincs
    Secrétaire
    PO BOX 16 New Oxford House
    Townhall Square
    DN31 1HE Grimsby
    Ne Lincs
    145596280001
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gdns
    KT22 0UQ Oxshott
    Leatherhead, Surrey
    Administrateur
    Oakridge House
    6 Montrose Gdns
    KT22 0UQ Oxshott
    Leatherhead, Surrey
    Danish145596290001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt-Nam-Breac
    Mill Lane
    LN11 8LT Legbourne
    Louth, Lincs
    Administrateur
    Allt-Nam-Breac
    Mill Lane
    LN11 8LT Legbourne
    Louth, Lincs
    EnglandBritish84487230001
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 OPN Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    93 High Street
    Waltham
    DN37 OPN Grimsby
    South Humberside
    British145596250001
    RUFFELL-WARD, Brian
    18a Stallingborough Road
    Healing
    DN37 7QN Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    18a Stallingborough Road
    Healing
    DN37 7QN Grimsby
    South Humberside
    British145596260001
    SUTHERLAND, Innes
    Sutherley Nook
    Church Lane
    Elsham
    Brigg,South Humberside
    Administrateur
    Sutherley Nook
    Church Lane
    Elsham
    Brigg,South Humberside
    EnglandBritish1064160001
    THOMAS, Andrew George
    "Pennyhill"
    177 Westella Road
    Hull
    North Humberside
    Administrateur
    "Pennyhill"
    177 Westella Road
    Hull
    North Humberside
    British145596240001

    SCOTTISH SEAFOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 06 nov. 2008
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage debenture. The lands and premises situate at and known as factory 2, the harbour, kilkeel, co down being the lands and premises comprised in folios 37777, DN17424, DN9403L and DN32585 all co down.
    Personnes ayant droit
    • Société Générale
    Transactions
    • 06 nov. 2008Enregistrement d'une charge
    Mortgage or charge
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies confirmatory mortgage debenture. Lands and premises situate at and known as factory 2, the harbour, kilkeel comprised in folios 37777, DN17424 DN9403L and DN32585 all co down.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 24 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Mortgage debenture - all monies. 1.By way of charge all that and those the lands and premises situate at and known as factory 2, the harbour, kilkeel, county down being the lands and premises comprised in folios 37777, dn 17424,. dn 9493L and dn 32585, all county down........
    Personnes ayant droit
    • Société Générale
    Transactions
    • 24 mars 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 19 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage debenture. By way of charge all that and those the lands and premises situate at and known as factory 2, the harbour, kilkeel, co down being the lands and premises comprised in folios 37777, DN17424, DN9403L and DN32585 all co down.
    Personnes ayant droit
    • Société Générale
    Transactions
    • 19 déc. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 19 mars 2002
    Livré le 05 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Security accession deed - all monies charge clause fixed charges - the company, as continuing security for the payment of the indebtedness, charged in favour of the security.................. (See doc 20 for further details).
    Personnes ayant droit
    • 41 Tower Hill
    • Societe Generale
    Transactions
    • 05 avr. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Deed of charge the lands and premises comprised in folios dn 32585, dn 9403L, dn 17424 and 37777, county down, being the property known as factory no 2, rooney road, kilkeel, county down.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Fixed charge on book debts and other receivables all the company's book debts and other receivables both present and future which are properly recoverable and enforceable in northern ireland.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Deed of charge the lands and premises comprised in folios 34728 and 34504, county down, being the property known as factory no 1 harbour road, kilkeel, county down.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Deed of charge. The lands and premises comprised in the whole of folio 28273, part of folio 33933, the whole of folio 32228 no 2 and part of folio 32228 no 1, county down and comprised in a transfer dated 10TH august 1998 between the department of economic development of the one part and scottish seafoods limited of the other part and shown edged with a red line on the plan annexed thereto.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Bond and floating charge the whole of the property (includin uncalled capital) see doc 5 for details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (402 NI)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0