VICO PROPERTY GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVICO PROPERTY GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI007925
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VICO PROPERTY GROUP LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe VICO PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o T MCCOURT & CO
    19 Bachelors Walk
    BT28 1XJ Lisburn
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VICO PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VICO PROPERTY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY28 mai 201528 mai 2015
    VICO PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY22 janv. 199222 janv. 1992
    VICO DEVELOPMENT LIMITED08 juin 197008 juin 1970

    Quels sont les derniers comptes de VICO PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour VICO PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de la réunion finale des créanciers

    1 pages4.44(NI)

    Nomination d'un liquidateur (judiciaire)

    1 pages4.32(NI)

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge NI0079250026 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 24 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 25 en totalité

    1 pagesMR04

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 déc. 2015

    État du capital au 23 déc. 2015

    • Capital: GBP 2,539.718
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 01 sept. 2015

    • Capital: GBP 2,363.4977
    3 pagesSH01

    Cessation de la nomination de Christopher Mark Carvill en tant que directeur le 06 août 2015

    1 pagesTM01

    Annulation d'actions. État du capital au 09 juil. 2015

    • Capital: GBP 2,363.4977
    4 pagesSH06

    Subdivision, reconversion des actions au 09 juil. 2015

    5 pagesSH02

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolutions

    Subdivision of shares; terms of contract approved 27/07/2015
    RES13

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital après une attribution d'actions au 09 juil. 2015

    • Capital: GBP 808,051.1036
    4 pagesSH01

    Rachat d'actions propres.

    3 pagesSH03

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014

    34 pagesAA

    Certificat de changement de nom et de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT11

    Réenregistrement des statuts

    18 pagesMAR

    Qui sont les dirigeants de VICO PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRYSON, Christopher Patrick
    c/o T Mccourt & Co
    Bachelors Walk
    BT28 1XJ Lisburn
    19
    Northern Ireland
    Secrétaire
    c/o T Mccourt & Co
    Bachelors Walk
    BT28 1XJ Lisburn
    19
    Northern Ireland
    179173380001
    CARVILL, Charles Joseph
    Well Road
    Warrenpoint
    BT34 3RS Newry
    29
    County Down
    Administrateur
    Well Road
    Warrenpoint
    BT34 3RS Newry
    29
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish979740003
    CARVILL, Micheal F.
    6 Rostrevor Terrace
    Orwell Road
    DUBLIN 6 Rathgal
    Administrateur
    6 Rostrevor Terrace
    Orwell Road
    DUBLIN 6 Rathgal
    IrelandIrish143134890001
    CARVILL, Thomas
    76 Killowen Old Road
    Killowen
    BT34 3AE Rostrevor
    Co Down
    Secrétaire
    76 Killowen Old Road
    Killowen
    BT34 3AE Rostrevor
    Co Down
    Irish201100001
    BOUCHE, Jean Michel
    Baycove Lodge
    Sandycove East Lane
    Sandycove
    Co Dublin
    Administrateur
    Baycove Lodge
    Sandycove East Lane
    Sandycove
    Co Dublin
    French80014410001
    CARVILL, Christopher Mark
    43 Corbett Road
    Katesbridge
    BT32 3SH Banbridge
    Co Down
    Administrateur
    43 Corbett Road
    Katesbridge
    BT32 3SH Banbridge
    Co Down
    Northern IrelandNorthern Irish81636250005
    CARVILL, Thomas
    Killowen Old Road
    Rostrevor
    BT34 3AE Newry
    76
    County Down
    Administrateur
    Killowen Old Road
    Rostrevor
    BT34 3AE Newry
    76
    County Down
    Northern IrelandIrish201100001
    MACCALLUM, Alasdair Norman
    Inverossie
    Rossie Brae
    DD10 9TJ Montrose
    Scotland
    Administrateur
    Inverossie
    Rossie Brae
    DD10 9TJ Montrose
    Scotland
    ScotlandBritish465170001
    SNEDDON, Richard
    28 St.Vincents Street South
    Stratford
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    28 St.Vincents Street South
    Stratford
    Ontario
    Canada
    CanadaBritish143134870001
    TAYLOR, Colin Michael
    Kirklea
    Gyffe Road
    PA13 4BA Kilmacolm
    Inverclyde
    Administrateur
    Kirklea
    Gyffe Road
    PA13 4BA Kilmacolm
    Inverclyde
    ScotlandBritish107860600001

    VICO PROPERTY GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 déc. 2013
    Livré le 31 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as land to the rear of 19-31 high street, cowdenbeath being the subjects registered in the land register of scotland under title number FFE98839.
    Personnes ayant droit
    • Awd Trustees Limited (As Trustee of the Vico Retirement Fund)
    • Colin Taylor (As Trustee of the Vico Retirement Fund)
    • Michael Carvill (As Trustee of the Vico Retirement Fund)
    Transactions
    • 31 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security executed on 12 november 2012
    Créé le 20 déc. 2012
    Livré le 07 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All and whole the subjects known as land to the rear of 19-31 high street, cowdenbeath being the subjects registered in the land register of scotland.
    Personnes ayant droit
    • Awd Trustees Limited
    • Colin Taylor
    • Michael Carvill
    Transactions
    • 07 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2011
    Livré le 30 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    That area or piece of land at high street, cowdenbeath, more particularly described as follows: all and whole (in the first place) all and whole that piece of ground extending to 2 acres and 9 one-thousandth part of an acre imperial measure or thereby, situated in the burgh of cowdenbeath and county of fife...see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer in Scotland
    Transactions
    • 30 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 01 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies charge. The premises comprised in folios DN92890 and DN6608, both county down.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 juin 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 18 avr. 2005
    Livré le 25 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies standard security.. Subject on the east of highfield drive, ayr, KA8 0LL registered under title number ayr 53852.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 25 avr. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 11 juin 2004
    Livré le 16 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies standard security subjects lying to the north west of auchenkilns roundabout, cumbernauld glasgow, title no dmb 72990.
    Personnes ayant droit
    • Glasgow
    • Governor & Co. Boi
    Transactions
    • 16 juin 2004Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 13 avr. 2004
    Livré le 19 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Standard security all sums all and whole the subjects lying to the north west of auchenkilns roundabout, cumbernauld, glasgow which subjects are registered in the land register of scotland under title deed number dmb 72990 together with the rights contained in the deed of conditions in entry 1 of the burdens section of the said land certificate.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Co
    • 19 St Vincents Place
    Transactions
    • 19 avr. 2004Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 27 juin 2001
    Livré le 16 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Standard security - all monies 30-34 and 38-54 king street, kilmarnock (otherwise known as phase 2, kilmarnock town centre), registered in the land registered of scotland under title number AYR35164 under exception of all and whole those subjects comprising 18-28 king street.......see doc no. 176 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 16 juil. 2001Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 15 mars 1996
    Livré le 05 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Standard security the heritable property comprising nos 129,133 and 135 george street, aberdeen being the subjects described in dispos- ition by carrycroft limited in favour of vico properties public limited company dated 12TH and recorded grs (aberdeen) 15TH march, 1996. property insurance proceeds: all rights benefits and claims (whether existing now or arising at any time in the future under the policy or policies of insur- ance for or covering the property or any interest in the property effected from time to time in accordance with the provisions of the deed of conditions.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 15 mars 1996
    Livré le 26 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Standard security those subjects comprising the ground and basement shop units known as and forming 129,133 and 135 george street, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Carrycroft Limited
    Transactions
    • 26 mars 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 06 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Standard security see doc 138 for details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 01 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Standard security 198 and 200 bath street, glasgow being the subjects registered in th land register under title number gla 117523.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 09 août 1995
    Livré le 10 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Legal charge 1. all that freehold land situate on east side of shrewsbury avenue, peter- borough, cambridgeshire as same is registered at hm land registry with freehold title absolute under title number cb 123262 together with buildings erections fixtures and fittings (save for any tenant's fittings) and fixed plant and machinery for time being there on and all improvements and additions thereto. 2. by way of floating charge all unfixed.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 10 août 1995Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 08 mai 1995
    Livré le 22 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Standard security all and whole the subjects situated on the north west of kyle st. Port dundas glasgow being the whole subjects regis- tered in the land register of scotland under title no. Gla 51795; together with (1) the whole buildings and erections (if any) thereon (2) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, (3) the whole fittings and fixtures therein and thereon and (4) the company's whole right title and interest present and future in and to the same. Plant machinery, materials goods, furniture and equipment now or from time to time upon the mortgaged premises.
    Personnes ayant droit
    • Lombard & Ulster
    Transactions
    • 22 mai 1995Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 06 déc. 1994
    Livré le 19 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Standard security 254/254A union st. & 39 union row aberdeen as relative to deposition in favour of claud hamilton (aberdeen) LTD recorded 22/5/1920. 2 bridge st. & 1 bruce st. Dunfermline as relative to desposition in favour william low & co LTD recorded 11/12/1951 30 royal terrace edinburgh as described in notarial instrument in favour of miss janet mackinlay & others as trustees recorded 31/7/1866 and 18 royal terrace mews, edinburgh as described in disposition in favour of annie evelyn rose, recorded 20.5. 1926. 4 & 5 golden square aberdeen as described in disposition in favour of kirkwood house (investments) LTD recorded 10.8.1978.
    Transactions
    • 19 déc. 1994Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 19 mars 1992
    Livré le 19 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Charge the lands and premises comprised in folio an 4004L county antrim.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 19 mars 1992Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 21 févr. 1989
    Livré le 24 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the lands comprised in folio nos AN4004L and AN5100L both county antrim and all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 24 févr. 1989Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 12 mai 1988
    Livré le 17 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage all that part of the lands comprised in folio 26407 county antrim held under flease dated 22/4/88. all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 17 mai 1988Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 15 févr. 1988
    Livré le 02 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the companys property being part of the lands comprised in folio nos 26641 and county antrim and also all machinery utensils chattels and things now or at any time fhereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Devel-
    Transactions
    • 02 mars 1988Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 10 mars 1986
    Livré le 12 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the companys premises at prospect mill flax street and ardilea street in the city of belfast held under a conveyance of 23/12/85 blackstaff properties LTD to vico developments limited.
    Personnes ayant droit
    • Lombard & Ulster
    Transactions
    • 12 mars 1986Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 03 déc. 1985
    Livré le 11 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage lands comprised in folio 25332 co antrim together withpart of the lands com- prised in folio 24791 co antrim and part of the lands comprised in folio 26641 co antrim held under lease dated 15/4/85 and also all machinery utensils chattels and things now or at any time herein- after upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Devel-
    Transactions
    • 11 déc. 1985Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 14 août 1985
    Livré le 21 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage premises situate in the townlands of kilmakee and derryaghy and county of antrim being part ofthe lands comprised in folio no 26641 county antrim together with machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Devel-
    Transactions
    • 21 août 1985Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 16 avr. 1985
    Livré le 17 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the companys leasehold land being part of the lands comprised in folio nos. 25332 and 24971 county antrim situate in the townland of derriaghy and county of antrim, and also all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Devel-
    Transactions
    • 17 avr. 1985Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 08 févr. 1984
    Livré le 08 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the companys property situate at 33 ferryquay street and 1 and 2 artillery street londonderry and also all mach- inery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Devel-
    Transactions
    • 08 févr. 1984Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 26 févr. 1981
    Livré le 18 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    150000
    Brèves mentions
    Mortgage "all that part of the lands of lisnagar- vey situate in the barony of upper massereene and county of antrim contain- ing twenty two and one quarter perches statute measure or thereabouts bounded on the north by town commissioners bye wash covered on the south by bow street on the east by samuel j nelson's pre- mises and on the west by william norwood representative premises as said pre- mises are now in the occupation of the purchaser or his undertenants and held by the purchaser under lease dated 16/4/1741 from frances baron conway to james greer for lives renewable forever" which said premises are situate at and knwon as 24 bow street, lisburn in the county of antrim.
    Personnes ayant droit
    • Charles Street
    Transactions
    • 18 mars 1981Enregistrement d'une charge (402 NI)

    VICO PROPERTY GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 juil. 2017Commencement of winding up
    16 sept. 2019Conclusion of winding up
    19 déc. 2019Due to be dissolved on
    11 juil. 2017Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Belfast
    Fermanagh House Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim
    practitioner
    Fermanagh House Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim
    Ken Pattullo
    Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West
    BT1 6JH Belfast
    practitioner
    Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West
    BT1 6JH Belfast

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0