MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED

MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI016891
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED ?

    • fabrication de structures métalliques et de parties de structures (25110) / Industries manufacturières
    • fabrication de portes et fenêtres en métal (25120) / Industries manufacturières

    Où se situe MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp Waterfront Plaza
    8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MCMULLEN GLASS LIMITED26 août 198326 août 1983

    Quels sont les derniers comptes de MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 03 déc. 2018

    18 pages2.24B(NI)

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    18 pages2.35B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 juin 2018

    12 pages2.24B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 déc. 2017

    13 pages2.24B(NI)

    Avis de prorogation de la période d'administration

    1 pages2.31B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 juin 2017

    12 pages2.24B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 déc. 2016

    13 pages2.24B(NI)

    Avis de prorogation de la période d'administration

    2 pages2.31B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 juin 2016

    15 pages2.24B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 déc. 2015

    13 pages2.24B(NI)

    Avis de prorogation de la période d'administration

    1 pages2.31B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 juin 2015

    15 pages2.24B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 déc. 2014

    8 pages2.24B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 juin 2014

    9 pages2.24B(NI)

    Avis de prorogation de la période d'administration

    1 pages2.31B(NI)

    Avis du résultat de la réunion des créanciers

    28 pages2.23B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 déc. 2013

    9 pages2.24B(NI)

    Avis de prorogation de la période d'administration

    1 pages2.31B(NI)

    Nomination d'un administrateur remplaçant/supplémentaire

    1 pages2.40B(NI)

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    11 pages2.39B(NI)

    Rapport d'avancement de l'administrateur au 04 juin 2013

    9 pages2.24B(NI)

    Exposé des propositions de l'administrateur

    27 pages2.17B(NI)

    Changement d'adresse du siège social de * 66 Lurgan Road Moira Craigavon Co Armagh BT67 0LX* le 10 déc. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B(NI)

    Qui sont les dirigeants de MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PENTLAND, John David
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT
    Secrétaire
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT
    British129637620001
    MCMULLEN, Edward Russell
    Greenmount
    205 Bangor Road
    BT18 0JG Holywood
    Co Down
    Administrateur
    Greenmount
    205 Bangor Road
    BT18 0JG Holywood
    Co Down
    Northern IrelandBritishDirector145717920001
    MILLS, Ronald Douglas
    6 Shanecracken Road
    Markethill
    BT60 1TS Co Armagh
    Administrateur
    6 Shanecracken Road
    Markethill
    BT60 1TS Co Armagh
    Northern IrelandBritishTechnical Engineer145717890001
    O'ROURKE, John Anthony
    18 Baronscourt Heights
    Carryduff
    BT8 Belfast
    Administrateur
    18 Baronscourt Heights
    Carryduff
    BT8 Belfast
    Northern IrelandBritishQuantity Surveyor145717880001
    PENTLAND, John David
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT Co Antrim
    Administrateur
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT Co Antrim
    Northern IrelandBritishChartered Accountant129637620001
    BAILIE, Thomas Holden
    12 Lambert Rise
    Dunlady Road
    BT16 0LQ Dundonald
    Belfast
    Administrateur
    12 Lambert Rise
    Dunlady Road
    BT16 0LQ Dundonald
    Belfast
    BritishCertified Accountant145717930001
    GIBSON, Patrick Coulter Maxwell
    15 Finaghy Park North
    Finaghy
    BT10 Belfast
    Administrateur
    15 Finaghy Park North
    Finaghy
    BT10 Belfast
    BritishDirector145717870001

    MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 08 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies debenture. Grants and demises unto the bank all freehold estates and interests in all freehold properties now or hereafter belonging to it together with the premises and the fixtures on and in them.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland Limited
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2008Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 13 sept. 2000
    Livré le 19 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Floating charge. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. N.B. the company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money otherwise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 19 sept. 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 13 sept. 2000
    Livré le 19 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Charge over all book debts. All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 19 sept. 2000
    Mortgage or charge
    Créé le 03 oct. 1996
    Livré le 22 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Charge on book debts all monies covenanted to be paid by the company and all present and future debts of the company and the proceeds of the same and all debts as set out in the schedule to the charge and the proceeds of same and the monies at all times standing to the credit of the specific bank account of the company.
    Personnes ayant droit
    • Icc Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 03 oct. 1996
    Livré le 22 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. First floating charge all the companys undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill.
    Personnes ayant droit
    • Icc Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 06 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 03 oct. 1996
    Livré le 22 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    200000
    Brèves mentions
    Assignment of life policy policy of assurance on the life of edward russell mcmullen granted by norwich union dated 19/7/91 being policy no. Ub 62000205 in the sum of #200,000 (two hundred thousand pounds sterling) and all monies assured or to become payable by or under the said policy.
    Personnes ayant droit
    • Icc Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 03 oct. 1996
    Livré le 22 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. First specific charge all its freehold and leasehold property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including the lands, hereditaments and premises at 66 lurgan road, moira, carigavon contained in folio no 37767 county down and dn 24818 county down together with all fixtures and fittings therein, its industrial plant whether fixed or moveable, computers, office and other equipment both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Icc Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 22 oct. 1993
    Livré le 27 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Assignation all that the companys right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the policies of insurance described in the schedule below and the right to exercise all powers and remedies for cancelling and/or enforcing the same schedule:- placing broker nelson hurst & marsh limited policy no. 63551458 date 03/09/03.
    Personnes ayant droit
    • Roy Scot Trust PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1993Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 07 oct. 1993
    Livré le 12 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the lands comprised in folio nos 37767 and dn 24818 county down, held in fee simple, together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 12 oct. 1993Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 09 juil. 1986
    Livré le 11 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 11 juil. 1986Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 09 juil. 1986
    Livré le 11 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Floating charge the undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. Nb. The company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money other- wise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 11 juil. 1986Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 30 avr. 1985
    Livré le 10 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the companys right title estate and interest in property situate at 13 logan drive, lurgan in the county of armagh and all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 10 mai 1985Enregistrement d'une charge (402 NI)

    MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 déc. 2012Administration started
    03 déc. 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Cave
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    practitioner
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    Paul Rooney
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    County Antrim
    practitioner
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    County Antrim
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0